DUNBIA (NORTHERN IRELAND)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNBIA (NORTHERN IRELAND)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société NI016970
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Adresse du siège social
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNGANNON MEATS26 mars 199826 mars 1998
    DUNGANNON MEATS LIMITED05 oct. 198305 oct. 1983

    Quels sont les derniers comptes de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01

    Inscription de la charge NI0169700025, créée le 29 juil. 2020

    75 pagesMR01

    Cessation de la nomination de James George Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Matthew Samuel Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge NI0169700024, créée le 29 juil. 2020

    42 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Dunbia (Uk) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    4 pagesPSC02

    Cessation de Dunbia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019

    3 pagesPSC07

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 17 déc. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2018

    31 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sean Breen en tant que secrétaire le 27 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 02 avr. 2017

    28 pagesAA

    Inscription de la charge NI0169700023, créée le 18 déc. 2017

    25 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone223137440001
    QUEALLY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Administrateur
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239899450002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Secrétaire
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239278860001
    DOBSON, James
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    Secrétaire
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    145673530001
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Secrétaire
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    British145673580002
    CULLEN, Paul Damien
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Administrateur
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Northern IrelandNorthern IrishFinance Director143854490001
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritishDirector130963600004
    DOBSON, James George
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritishManaging Director216974160001
    DOBSON, Robert John
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector60768390001
    DORAN, Michael
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishSales Director145673620002
    FARRELL, David Allan Raymond
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishIt Director145673660002
    GRAHAM, Edison Wilson
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandIrishChairman145110860001
    HANGER, Trevor
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    UkBritishDirector163090380001
    MCKEAVNEY, Robert Edward
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Administrateur
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Northern IrelandBritishFinancial Director60391320001
    MCKEOWN, Alan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishOperations Director145673610002
    MILLIGAN, Gordon John
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Administrateur
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Northern IrelandBritishH R Director145673640001
    POTTS, Colin Edwin
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishCompany Director125726160003
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishHuman Resource Manager145673580002
    SWANN, Kenneth Thomas
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishCo Director145673590002
    TWEEDIE, Henry Campbell
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Administrateur
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Northern IrelandBritishCo Director48171740001
    YOUNG, Jonathan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Administrateur
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector148532740002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    29 nov. 2019
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    Non
    Forme juridiqueUnlimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03382084
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    Oui
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementNorthern Ireland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies House
    Numéro d'enregistrementNi059523
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DUNBIA (NORTHERN IRELAND) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2020
    Livré le 11 août 2020
    En cours
    Brève description
    Factory facilities and offices being land and buildings known as site a, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with freehold number TY62002 county tyrone and leasehold folio numbers TY3069L, TY1647L, TY4950L, TY10143L, TY11270L and TY65783L all county tyrone and the retail packing facility being land and buildings known as site b, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with leasehold folio number TY13162L county tyrone, specific intellectual property as outlined in the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 11 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2020
    Livré le 10 août 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 déc. 2017
    Livré le 22 déc. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The "Lender")
    Transactions
    • 22 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 18 oct. 2017
    En cours
    Brève description
    Real property, shares and investments and specified intellectual property, for more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 18 oct. 2017
    En cours
    Brève description
    Non-vesting debts. For more details please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 06 oct. 2017
    Livré le 18 oct. 2017
    En cours
    Brève description
    Real property, shares and investments, specific intellectual property, relevant contracts, for more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 juil. 2014
    Livré le 05 août 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 05 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2014
    Livré le 12 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 2011
    Livré le 23 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 23 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 19 oct. 2010
    Livré le 03 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (A) granted and demised unto the bank all of the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 03 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 oct. 2010
    Livré le 18 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement...see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 18 déc. 2008
    Livré le 23 déc. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    £1,7000,000.00 mortage. The lands comprised in folios 6195 co tyrone, TY9521L co tyrone, TY10143L co tyrone, TY11270L co tyrone and 13070L co antrim.
    Personnes ayant droit
    • Premier Pension Trustees Limited
    Transactions
    • 23 déc. 2008Enregistrement d'une charge (402R NI)
    • 09 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 24 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies company mortgage and charge. All lands comprised in folio TY65783L co tyrone.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 02 déc. 2002
    Livré le 09 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage lands comprised in folio TY13162L county tyrone........................... See doc 73 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 09 déc. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 18 juil. 2001
    Livré le 23 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Mortgage - all monies the lands comprised in folio AN12756L co antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 23 juil. 2001Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 11 mai 1989
    Livré le 16 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and premises in folio nos ty 3069L and ty 4950L and all machinery utensils chattels.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 16 mai 1989
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 09 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Pieces or parcels of ground at dungannon park dungannon county tyrone all machinery utensils chattels.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 10 févr. 1988
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 17 déc. 1987
    Livré le 30 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Portion of ground in the townland of cormullagh folio ty 1647L county tyrone all machinery utensils chattels.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1987
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattels mortgage
    Créé le 27 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Chattels being one jnf power pack serial number FPP6650, fifteen searl coils serial numbers 2 x lci 614/8 x LC5 1014/ 1 x LC3 814/ 3 x SH4 6/6 1 x kgl 180, one baltimore evaporator condensor serial number BC1528.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1986
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Chattels being one new toyota forklift serial number 10277, one harmonica roller serial number HRC7, one vac pack bags table serial number vpbt 1500/750, ten bag holders, one strip curtain, one breaking bar.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1986
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Chattels being one atlas copco GA230 compressor one glass fibre tank capacity 3. 8490 litres serial no. GFT38490, one beaumont hot water generator serial no. 5060HZ, one beef hidepuller serial no. 151F0201.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1986
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All chattels being one 4150CTN/el/fb/ba overhead scale, one 4150CTN/ll/r/kb/bj overhead scale.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1986
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 27 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All chattels being bleed rail serial number BR1 rails in slaughterhall marshalling area 8 rails in sides chills quarters chill boning room and detained room for details of further chattels charged please refer to the form.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 27 oct. 1986
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over all book debts
    Créé le 28 nov. 1983
    Livré le 30 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 30 nov. 1983
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 28 nov. 1983
    Livré le 30 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 30 nov. 1983
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0