DUNBIA (NORTHERN IRELAND)
Vue d'ensemble
Nom de la société | DUNBIA (NORTHERN IRELAND) |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | NI016970 |
Juridiction | Irlande du Nord |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?
Adresse du siège social | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Inscription de la charge NI0169700025, créée le 29 juil. 2020 | 75 pages | MR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James George Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Samuel Dobson en tant que directeur le 29 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Inscription de la charge NI0169700024, créée le 29 juil. 2020 | 42 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 janv. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Dunbia (Uk) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019 | 4 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Dunbia Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 nov. 2019 | 3 pages | PSC07 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 17 déc. 2019
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 déc. 2018 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sean Breen en tant que secrétaire le 27 févr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 02 avr. 2017 | 28 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge NI0169700023, créée le 18 déc. 2017 | 25 pages | MR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREEN, Sean | Administrateur | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | None | 239253300004 | ||||
BROWNE, Niall | Administrateur | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | None | 223137440001 | ||||
QUEALLY, Michael | Administrateur | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | Ireland | Irish | None | 239899450002 | ||||
BREEN, Sean | Secrétaire | Grannagh Waterford C/O Dawn Meats Ireland | 239278860001 | |||||||
DOBSON, James | Secrétaire | 98 Old English Road Dungannon Co Tyrone | 145673530001 | |||||||
PROCTOR, John Joseph | Secrétaire | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | British | 145673580002 | ||||||
CULLEN, Paul Damien | Administrateur | 19 Ravensdale Manse Road BT36 6FA Carnmoney Co Antrim | Northern Ireland | Northern Irish | Finance Director | 143854490001 | ||||
DEMPSEY, Liam Joseph | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | United Kingdom | British | Director | 130963600004 | ||||
DOBSON, James George | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Director | 60391230001 | ||||
DOBSON, Matthew Samuel | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | United Kingdom | British | Managing Director | 216974160001 | ||||
DOBSON, Robert John | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Director | 60768390001 | ||||
DORAN, Michael | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Sales Director | 145673620002 | ||||
FARRELL, David Allan Raymond | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | It Director | 145673660002 | ||||
GRAHAM, Edison Wilson | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | Irish | Chairman | 145110860001 | ||||
HANGER, Trevor | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Uk | British | Director | 163090380001 | ||||
MCKEAVNEY, Robert Edward | Administrateur | 25 Coachmans Way Culcavy BT26 6HQ Hillsborough Co Down | Northern Ireland | British | Financial Director | 60391320001 | ||||
MCKEOWN, Alan | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Operations Director | 145673610002 | ||||
MILLIGAN, Gordon John | Administrateur | 10 Grangee Road Carrowdore BT22 2JB Newtownards | Northern Ireland | British | H R Director | 145673640001 | ||||
POTTS, Colin Edwin | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Company Director | 125726160003 | ||||
PROCTOR, John Joseph | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Human Resource Manager | 145673580002 | ||||
SWANN, Kenneth Thomas | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Co Director | 145673590002 | ||||
TWEEDIE, Henry Campbell | Administrateur | Stonethorpe Cottage 116 Belfast Road BT23 4TY Newtownards Co Down | Northern Ireland | British | Co Director | 48171740001 | ||||
YOUNG, Jonathan | Administrateur | Granville Industrial Estate Dungannon BT70 1NJ Co Tyrone | Northern Ireland | British | Director | 148532740002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunbia (Uk) | 29 nov. 2019 | Castle Street EX4 3LG Exeter Michael House Devon England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Dunbia Limited | 06 avr. 2016 | Granville Road BT70 1NJ Dungannon Unit 9 Northern Ireland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
DUNBIA (NORTHERN IRELAND) a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 29 juil. 2020 Livré le 11 août 2020 | En cours | ||
Brève description Factory facilities and offices being land and buildings known as site a, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with freehold number TY62002 county tyrone and leasehold folio numbers TY3069L, TY1647L, TY4950L, TY10143L, TY11270L and TY65783L all county tyrone and the retail packing facility being land and buildings known as site b, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with leasehold folio number TY13162L county tyrone, specific intellectual property as outlined in the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 29 juil. 2020 Livré le 10 août 2020 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 18 déc. 2017 Livré le 22 déc. 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 06 oct. 2017 Livré le 18 oct. 2017 | En cours | ||
Brève description Real property, shares and investments and specified intellectual property, for more details please refer to the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 06 oct. 2017 Livré le 18 oct. 2017 | En cours | ||
Brève description Non-vesting debts. For more details please refer to the instrument. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 06 oct. 2017 Livré le 18 oct. 2017 | En cours | ||
Brève description Real property, shares and investments, specific intellectual property, relevant contracts, for more details please refer to the instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 24 juil. 2014 Livré le 05 août 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 27 févr. 2014 Livré le 12 mars 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 déc. 2011 Livré le 23 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 19 oct. 2010 Livré le 03 nov. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (A) granted and demised unto the bank all of the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 18 oct. 2010 Livré le 18 oct. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement...see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage or charge | Créé le 18 déc. 2008 Livré le 23 déc. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti 0 | |
Brèves mentions £1,7000,000.00 mortage. The lands comprised in folios 6195 co tyrone, TY9521L co tyrone, TY10143L co tyrone, TY11270L co tyrone and 13070L co antrim. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage or charge | Créé le 24 août 2007 Livré le 31 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti 0 | |
Brèves mentions All monies company mortgage and charge. All lands comprised in folio TY65783L co tyrone. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage or charge | Créé le 02 déc. 2002 Livré le 09 déc. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti 0 | |
Brèves mentions All monies mortgage lands comprised in folio TY13162L county tyrone........................... See doc 73 for further details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage or charge | Créé le 18 juil. 2001 Livré le 23 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti 0 | |
Brèves mentions Mortgage - all monies the lands comprised in folio AN12756L co antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 11 mai 1989 Livré le 16 mai 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and premises in folio nos ty 3069L and ty 4950L and all machinery utensils chattels. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 09 févr. 1988 Livré le 10 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Pieces or parcels of ground at dungannon park dungannon county tyrone all machinery utensils chattels. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 17 déc. 1987 Livré le 30 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Portion of ground in the townland of cormullagh folio ty 1647L county tyrone all machinery utensils chattels. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 27 oct. 1986 Livré le 27 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Chattels being one jnf power pack serial number FPP6650, fifteen searl coils serial numbers 2 x lci 614/8 x LC5 1014/ 1 x LC3 814/ 3 x SH4 6/6 1 x kgl 180, one baltimore evaporator condensor serial number BC1528. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 24 oct. 1986 Livré le 27 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Chattels being one new toyota forklift serial number 10277, one harmonica roller serial number HRC7, one vac pack bags table serial number vpbt 1500/750, ten bag holders, one strip curtain, one breaking bar. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 24 oct. 1986 Livré le 27 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Chattels being one atlas copco GA230 compressor one glass fibre tank capacity 3. 8490 litres serial no. GFT38490, one beaumont hot water generator serial no. 5060HZ, one beef hidepuller serial no. 151F0201. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 24 oct. 1986 Livré le 27 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All chattels being one 4150CTN/el/fb/ba overhead scale, one 4150CTN/ll/r/kb/bj overhead scale. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattels mortgage | Créé le 24 oct. 1986 Livré le 27 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All chattels being bleed rail serial number BR1 rails in slaughterhall marshalling area 8 rails in sides chills quarters chill boning room and detained room for details of further chattels charged please refer to the form. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over all book debts | Créé le 28 nov. 1983 Livré le 30 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 28 nov. 1983 Livré le 30 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0