AP (NI) (NO.1) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAP (NI) (NO.1) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI024802
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    Co Antrim
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    E.A. BAIRD (N'ARDS) LIMITED06 juil. 199506 juil. 1995
    WM. MARTIN (N'ARDS) LIMITED12 sept. 199012 sept. 1990

    Quels sont les derniers comptes de AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mai 2012

    État du capital au 14 mai 2012

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher James Giles en tant que directeur le 05 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Francis Muller en tant qu'administrateur le 05 sept. 2011

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    13 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    4 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de AP (NI) (NO.1) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Secrétaire
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150395280001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Administrateur
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Administrateur
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    BAIRD, Irene Deirdre
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Secrétaire
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    144417380001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    AU COSEC LIMITED
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    Secrétaire
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    68799430002
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrey
    Administrateur
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrey
    United KingdomBritish59741430002
    BAIRD, Austin Richard
    48 Circular Road
    Belmont
    BT4 2GB Belfast
    County Antrim
    Administrateur
    48 Circular Road
    Belmont
    BT4 2GB Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritish143001420001
    BAIRD, Catherine Jane
    9 Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Administrateur
    9 Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    British144417440001
    BAIRD, Ernest
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Administrateur
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    British144417390001
    BAIRD, Irene Deirdre
    9 Rosepark East
    Dundonald
    BT5 7RL
    Administrateur
    9 Rosepark East
    Dundonald
    BT5 7RL
    British144417410001
    CASEMENT, Diane Elizabeth
    12 Middle Road
    Saintfield
    BT24 7LP
    Administrateur
    12 Middle Road
    Saintfield
    BT24 7LP
    British144417430001
    GILES, Christopher James
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim
    Administrateur
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim
    EnglandBritish150046230001
    HULME, Simon
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    Administrateur
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    United KingdomBritish105524430001
    JOHNSTON, Alison Mary Louise
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    Administrateur
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    British144417450001
    JOHNSTON, Colin James
    12 Gowan Heights
    Drumbeg Road
    BT17 9LZ Drumbeg
    Belfast
    Administrateur
    12 Gowan Heights
    Drumbeg Road
    BT17 9LZ Drumbeg
    Belfast
    Northern IrelandBritish144317390001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Tamarind
    Camilla Drive
    RH5 6BU Westhumble
    Dorking
    Administrateur
    Tamarind
    Camilla Drive
    RH5 6BU Westhumble
    Dorking
    EnglandBritish151240810001

    AP (NI) (NO.1) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage or charge
    Créé le 31 janv. 2005
    Livré le 08 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage/charge. Premises situate at 42 and 44 holywood rad, belfast.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 23 août 2004
    Livré le 23 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage / charge all that the lands and premises situate at 56A rathmore road, carnalea, bangor, county down BT19 1WL...... See doc 64 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 23 août 2004Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 30 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 18 mars 2003
    Livré le 20 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage and counterpart mortgage. All of the land comprised in folio no. Dn 104360 county down and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of the security become the property of the company.
    Personnes ayant droit
    • Dublin 2 and Ulster
    • Donegall Square East
    • Ulster Bank Ireland
    Transactions
    • 20 mars 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 11 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 04 oct. 2002
    Livré le 15 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. The premises at the square 2-4 fair green road marjethill county armagh the dispensing pharmaceutical licence....... ........................................ see doc 59 for further details.
    Personnes ayant droit
    • And Ulster Bank
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 15 oct. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage the leasehold premises at units NO3 & 7 sailsbury square, queen street ballymena co antrim............................... See doc 60 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • Bank Limited
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 11 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 13 sept. 2002
    Livré le 23 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. The premises situate at 97-107, high street, bangor, county down being the lands and premises more particularly described in deed of conveyance and assignment dated the 13TH day of september 2002 and made between stranmillis investments limited of the one part and the mortgagor of the other see doc 56 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • Dublin 2 and Ulster
    • Donegall Square East
    Transactions
    • 23 sept. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 31 juil. 2002
    Livré le 02 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. The leasehold premises at 72 holywood road, belfast, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor.
    Personnes ayant droit
    • 11-16 Donegall
    • Quay Dublin 2 And
    • Ulster Bank Ireland
    Transactions
    • 02 août 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 29 juil. 2002
    Livré le 02 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. The leasehold premises at 13 john mitchel place, newry, county down, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • 11-16 Donegall
    • Quay, Dublin 2 And
    Transactions
    • 02 août 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 01 juil. 2002
    Livré le 05 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. The leasehold premises at 83, the promenade, portstewart, co londonderry, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery......................... See doc 53 for further details.
    Personnes ayant droit
    • 11-16 Donegall Sq
    • Ulster Bank Ireland
    • Dublin 2 And
    Transactions
    • 05 juil. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 31 mai 2002
    Livré le 07 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. All that and those lands situate at chapel hill, lisburn, county antrim as are comprised in deed of conveyance dated 31ST may 2002 and made between thomas hague and pauline hague of the one part and mortgagor of the other part. See doc 52 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    Transactions
    • 07 juin 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 04 mars 2002
    Livré le 12 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Mortgage - all monies. The leasehold premises at 9, high street lurgan........ See doc. No. 51 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 12 mars 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 01 juil. 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 80A main street, cullybackey, county antrim together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment thereon.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 30 juin 2000
    Livré le 05 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 324 beersbridge road, belfast together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank LTD
    • Ulster Bank Markets
    Transactions
    • 05 juil. 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 28 nov. 1997
    Livré le 02 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. Premises situate and known as 17 and 19 hillsborough road, dromara, county down together with all fixed and moveable plant and machinery implements utensils furniture and equipment and together also with the dispensing pharmaceutical license.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transactions
    • 02 déc. 1997Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 31 juil. 1996
    Livré le 31 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage debenture see doc 31 for details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Markets
    Transactions
    • 31 juil. 1996Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 30 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 23 août 1995
    Livré le 01 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage the premises situate and known as nos. 104, 106 and 108 frances street, newtownards. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank LTD
    Transactions
    • 01 sept. 1995Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 06 juin 1994
    Livré le 14 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies charge over all book debts.. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 14 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (411A NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 06 juin 1994
    Livré le 14 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies floating charge.. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See 402 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 14 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (411A NI)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0