CAPITA HELM CORPORATION LIMITED

CAPITA HELM CORPORATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAPITA HELM CORPORATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI025165
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bedford House
    16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRIBAL HELM CORPORATION LIMITED12 nov. 200412 nov. 2004
    HELM CORPORATION LIMITED - THE16 sept. 199116 sept. 1991
    CSL (N.I.) LIMITED28 déc. 199028 déc. 1990

    Quels sont les derniers comptes de CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Procès-verbal de la réunion finale dans une liquidation volontaire des associés

    3 pages4.72(NI)

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Beacon House 27 Clarendon Road Belfast BT1 3PR à Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT le 26 nov. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur

    1 pagesVL1

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.71(NI)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    insolvency

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESM(NI)

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 oct. 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2018

    17 pagesAA

    legacy

    201 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Francesca Anne Todd le 15 juin 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Capita Corporate Director Limited le 15 juin 2018

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 15 juin 2018

    1 pagesCH04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    legacy

    208 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Secrétaire
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Administrateur
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    EnglandBritish72249980003
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Administrateur
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5641516
    129795770003
    COLLINS, Richard Hawke
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    British53398040001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Secrétaire
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    150939630001
    MALLON, Martin Columba
    73 Granville Road
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Secrétaire
    73 Granville Road
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    143259400001
    BREACH, Stephen Derrick
    Newman Street
    W1T3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Administrateur
    Newman Street
    W1T3EY London
    87-91
    United Kingdom
    United KingdomBritish147928530001
    BUCKLEY, William David
    166 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0TN Ballyclare
    Administrateur
    166 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0TN Ballyclare
    United KingdomBritish143259420001
    COTSFORD, Lee Douglas
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish184974410001
    DUFFY, Damian Hugh
    28 Springhill Manor
    Magheralin
    BT67 0UB County Armagh
    Administrateur
    28 Springhill Manor
    Magheralin
    BT67 0UB County Armagh
    Irish143259470001
    FIELD, Andrew
    12 The Mount
    New Malden
    KT3 4HU Surrey
    Administrateur
    12 The Mount
    New Malden
    KT3 4HU Surrey
    EnglandBritish61471170001
    FRAZER, Michael Robert
    129 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RR Carrickfergus
    Administrateur
    129 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RR Carrickfergus
    British61027100001
    GALBRAITH, John
    7 The Coaches
    Brown's Brae
    BT18 0LE Holywood
    Administrateur
    7 The Coaches
    Brown's Brae
    BT18 0LE Holywood
    British67079750001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane
    GL54 4BP Withington
    Cheltenham, Gloucestershire
    Administrateur
    Long Ash
    Woodbridge Lane
    GL54 4BP Withington
    Cheltenham, Gloucestershire
    British143259480001
    MACGINTY, Thomas Manus
    1 Ardgannon
    Dungannon
    Co Tyrone
    Administrateur
    1 Ardgannon
    Dungannon
    Co Tyrone
    Irish143259430001
    MARTIN, Peter John
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wargrave
    Berkshire, England
    Administrateur
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wargrave
    Berkshire, England
    EnglandBritish176044430001
    RICKATSON, Caroline
    Demesne Court
    88 Main Street
    BT67 0LH Moira
    Helm House
    County Armagh
    Northern Ireland
    Administrateur
    Demesne Court
    88 Main Street
    BT67 0LH Moira
    Helm House
    County Armagh
    Northern Ireland
    ScotlandBritish155008870001
    ROWLING, Keith Peter
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish109045590002
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritish132651920002
    SWEENEY, Sean Pacelli
    The Green
    Kilbroney Mill
    Kilbroney Road
    Rostrevor
    Administrateur
    The Green
    Kilbroney Mill
    Kilbroney Road
    Rostrevor
    United KingdomIrish61027110001
    WILLIAMS, Gareth Leslie Arnold
    4 Elsmore Manor
    Belfast
    BT5 7QD
    Administrateur
    4 Elsmore Manor
    Belfast
    BT5 7QD
    United KingdomBritish143259460001
    WYLLIE, Mark Richard John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish62362970002
    WYLLIE, Mark Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    EnglandBritish62362970002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    06 avr. 2016
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06027254
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CAPITA HELM CORPORATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 juin 2008
    Livré le 20 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage debenture. The company as beneficial owner and as a security for the payment and discharge of the secured obligations.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 2008Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 04 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 13 juin 2008
    Livré le 20 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies deed of accession. The company with full title guarantee has charged with thepayment and discharge to the security trustee as agent and trustee aforesaid of all the secured liabilities.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 2008Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 04 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Standard security
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 10 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies standard security. Flat 4/07, 5 south frederick street, glasgow G1 1HJ being the subjects registered under title no GLA173070.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 10 mai 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 26 oct. 2006
    Livré le 16 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies legal mortgage. 17 cottesbrooke park, heartlands, davantry, northants (formerly plot 6) comprised in part NN236150.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 09 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies.debenture the following property is specifically referred to:- all that and those the leasehold property known as unit 2, site 3, cromac wood, belfast comprised in a lease dated 9TH may 2000 and made between cusp limited of the one part and the helm corporation limited of the other part and being part of the lands comprised in folio no AN60856L county antrim. See doc 37 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies.assignmenmt of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069374 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of sean pacelli sweeney in the sum of #315,000.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069353 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of william david buckley in the sum of #131,761.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069364 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of robert michael frazer in the sum of #315,000.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069347 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of thomas manus macginty in the sum of #123,900.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Ireland
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 26 juil. 1999
    Livré le 30 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Mortgage/debenture a) a specific equitable charge over all future estates or interests in the property hereinafter described and over the companys estate or interest in all freehold or leasehold properties now or at any time belonging to or charged to the company other than the property hereinafter described.b) a specific charge over all book and other debts for the time being due or owing to the company but so that the company shall pay into the companys account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or other- wise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to the bank. C) a specific charge over its goodwill and the benefit of any licences and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for the time being the companys property. D) a floating charge over the undertaking and all other pro- perty and assets present and future but so that the company shall not without the banks consent create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this charge.
    Personnes ayant droit
    • East
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 30 juil. 1999Enregistrement d'une charge (402 NI)

    CAPITA HELM CORPORATION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 oct. 2019Commencement of winding up
    09 oct. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    practitioner
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0