CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR
Vue d'ensemble
Nom de la société | CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
Numéro de société | NI037439 |
Juridiction | Irlande du Nord |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
Adresse du siège social | 31 Bruce Street BT2 7JD Belfast Northern Ireland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 nov. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 nov. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 nov. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Ms Rachel Long en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Joe Mcvey en tant qu'administrateur le 01 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Dallas en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2024 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Anne-Marie Marie Mcclure en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 oct. 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Karen Gilmore en tant que directeur le 30 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Flynn en tant que directeur le 30 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Paula Ewart en tant qu'administrateur le 30 oct. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de Karen Gilmore en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 oct. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Irvine en tant que directeur le 31 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 33 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Fiona Mccabe en tant qu'administrateur le 24 oct. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anne-Marie Marie Mcclure en tant que directeur le 24 oct. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Jayne Murray en tant qu'administrateur le 01 déc. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gerard Deane en tant que directeur le 01 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 38 pages | AA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 33 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 33 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Martin Flynn en tant qu'administrateur le 03 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de Andrew Ross Mccracken en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 nov. 2020 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDEN, Jacinta | Secrétaire | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | 289395460001 | |||||||
BRYSON, Peter | Administrateur | Richmond Park Finaghy BT10 0HB Belfast 15 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Head Of County | 277570140001 | ||||
CUNNANE, Declan | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Ceo | 143789820001 | ||||
EWART, Paula | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Company Director | 329178810001 | ||||
HAMPTON, Nigel Robert | Administrateur | Glen Road Ballyward BT31 9QT Castlewellan 7 Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | Director | 190137900002 | ||||
LINDEN, Jacinta | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 217559800001 | ||||
LONG, Rachel | Administrateur | Amelia Street BT2 7GS Belfast 4 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Director Of Operations | 331000230001 | ||||
MCALPIN, Jonathan Scott | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Ceo | 157906970001 | ||||
MCCABE, Fiona | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Chief Executive | 316291780001 | ||||
MCVEY, Joe | Administrateur | South Parade BT7 2GL Belfast 17 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Management Consultant | 149491650002 | ||||
MURRAY, Jayne | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Pr Consultant | 260336500001 | ||||
ALLEN, Margaret Joy | Secrétaire | 26 Newtownbreda Road Belfast BT8 6AS | British | 144572740002 | ||||||
MARLEY, Josephine | Secrétaire | 4 Slieveban Drive BT11 8HF Belfast | 144712730001 | |||||||
MCCLOSKEY, Majella | Secrétaire | 123 Glen Road Belfast BT11 8BJ Co Antrim | Irish | 208556060002 | ||||||
MCCREANOR, Tracey Edith | Secrétaire | Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast The Volunteer Centre Northern Ireland | 184660020001 | |||||||
SMITH, Nora | Secrétaire | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | 209068380001 | |||||||
ANTHONY, Kerry | Administrateur | 38 University St BT7 1FZ Belfast Depaul Ireland Uk | Northern Ireland | British | Director | 164895930001 | ||||
BAMFORD, Erica Gayle | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Ceo | 239371560001 | ||||
CASH, Cara Maria | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | Ceo | 217499110002 | ||||
COLLINS, Karen Elizabeth | Administrateur | Ardoyne Road BT14 7HX Belfast 25 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Charity Ceo | 197361430001 | ||||
CROSSIN, Marie | Administrateur | 17 Ravenhill Park Gardens Belfast BT4 | N Ireland | Chief Executive | 144712750001 | |||||
CROSSIN, Marie | Administrateur | 17 Ravenhill Park Gardens Belfast BT | N Ireland | Chief Executive | 144712760001 | |||||
CROTHERS, Gary John | Administrateur | 6 Barnetts Road Belfast BT5 7BA | Irish | Director Acet In Ireland | 144712660001 | |||||
CURRAN, Dermot Joseph | Administrateur | 11 Elmfield Avenue Newtownabbey BT36 7RS | Northern Ireland | Irish | Chief Exectutive Officer | 143725890001 | ||||
DALLAS, Stephen | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Chief Executive | 143036040001 | ||||
DEANE, Gerard | Administrateur | Bishop Street BT48 6PW Londonderry 10-14 Northern Ireland | Ireland | Irish | Director | 277551450001 | ||||
DEVLIN, Joan | Administrateur | Salisbury Avenue BT15 5EA Belfast 64 County Antrim | Northern Ireland | Irish | Director | 143587010001 | ||||
DEVLIN, Richard | Administrateur | 118 Tullynakill Ardmillan BT23 6QP Killinchy | British | Centre Manager | 144712800001 | |||||
DONAGHY, Geraldine | Administrateur | 16 Highfield Drive Dublin Road BT35 8UQ Newry | Northern Ireland | Irish | Charity Manager | 143673530001 | ||||
FERGUSON, Gail | Administrateur | 26 Old Manse Green Banbridge BT32 4RY Co Down | Director | 144712810001 | ||||||
FLECK, Kathleen Roseann | Administrateur | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Northern Ireland | British | Director Of Charity | 179347370001 | ||||
FLYNN, Martin | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | Chief Executive | 215672510001 | ||||
FULTON, Jennifer | Administrateur | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Northern Ireland | British | Ceo | 171002320001 | ||||
GILMORE, Karen | Administrateur | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Northern Ireland | British | Commercial Director | 254227420001 | ||||
HILL, Judith Eileen | Administrateur | 77 Ardmore Heights Holywood BT18 0PY Co Down | Northern Ireland | British | Chief Executive Officer | 144712780001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CO3 CHIEF OFFICERS THIRD SECTOR ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Ms Karen Gilmore | 12 déc. 2018 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Miss Cara Maria Cash | 18 oct. 2017 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Erica Gayle Bamford | 18 oct. 2017 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Jennifer Fulton | 18 oct. 2017 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Declan Cunnane | 18 oct. 2017 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Jonathan Scott Mcalpin | 18 oct. 2017 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Anne-Marie Marie Mcclure | 20 oct. 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Jacinta Linden | 20 juin 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Non |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Paula Jennings | 01 juin 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Celine Mcstravick | 01 juin 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Nora Smith | 01 juin 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Andrew Ross Mccracken | 01 juin 2016 | Bruce Street BT2 7JD Belfast 31 Northern Ireland | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Patrick Minne | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Kate Fleck | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Lauri Gerald Gabriel Mccusker | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: Northern Irish Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Karen Collins | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Kerry Anthony | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Ms Kathleen Alice Laverty | 01 juin 2016 | The Volunteer Centre 34 Shaftesbury Square BT2 7DB Belfast | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0