BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED

BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI039295
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5th Floor Craig Plaza
    51-55 Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    Antrim
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNLOE EWART (6 LANYON PLACE) LIMITED19 sept. 200019 sept. 2000

    Quels sont les derniers comptes de BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    2 pagesMR04

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Nicholas Emlyn Peter Reid en tant que directeur le 30 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2015

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Francis Edward Boyd en tant que directeur le 01 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 oct. 2015

    État du capital au 29 oct. 2015

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de The Linenhall 7th Floor 32-38 Linenhall Street Belfast BT2 8BG à 5th Floor Craig Plaza 51-55 Fountain Street Belfast Antrim BT1 5EB le 20 août 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2014

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2014

    État du capital au 22 sept. 2014

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 sept. 2013

    État du capital au 23 sept. 2013

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2012

    11 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CREIGHTON, David Andrew
    51-55 Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    5th Floor Craig Plaza
    Antrim
    Northern Ireland
    Secrétaire
    51-55 Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    5th Floor Craig Plaza
    Antrim
    Northern Ireland
    British83528100001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Administrateur
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritishDirector83528100001
    BOYD, Francis Edward
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    Administrateur
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    Northern IrelandNorthern IrishDirector83528370002
    BYRNE, Philip
    13 Trafalgar Terrace
    Monkstown
    Dublin
    Administrateur
    13 Trafalgar Terrace
    Monkstown
    Dublin
    IrishDirector143626310001
    DEENY, Dominic
    15 Liska Avenue
    Dublin Road
    BT34 Newry
    Administrateur
    15 Liska Avenue
    Dublin Road
    BT34 Newry
    BritishChartered Surveyor18630090002
    ELLIOTT, Acheson
    57 Craigdarragh Road
    Helen's Bay
    BT19 1UB Co Down
    Administrateur
    57 Craigdarragh Road
    Helen's Bay
    BT19 1UB Co Down
    Northern IrelandBritishDirector144365710001
    GILLIGAN, Barry Christopher
    4 Malone Park
    Belfast
    BT9 6NH
    Administrateur
    4 Malone Park
    Belfast
    BT9 6NH
    Northern IrelandBritishDirector144728130001
    KENNY, Timothy
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    Dublin 13
    Administrateur
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    Dublin 13
    IrelandIrishFinance Director143346560001
    LEITCH, David Andrew
    64 Glenmachan Road
    Belfast
    BT4 2NN Co Antrim
    Administrateur
    64 Glenmachan Road
    Belfast
    BT4 2NN Co Antrim
    BritishSolicitor143626270001
    MCCABE, Damian Charles
    2 Greenane Drive
    Blacks Road
    BT10 ONH Belfast
    Co Antrim
    Administrateur
    2 Greenane Drive
    Blacks Road
    BT10 ONH Belfast
    Co Antrim
    BritishPupil Solicitor143626280001
    NOLAN, Geraldine
    620 Clonard Road
    Crumlin
    Dublin
    Administrateur
    620 Clonard Road
    Crumlin
    Dublin
    IrishAccountant143626330001
    PATTISON, Eric
    10 Oak Fern
    Glengormley
    BT36 5FN Antrim
    Administrateur
    10 Oak Fern
    Glengormley
    BT36 5FN Antrim
    BritishChartered Accountant64178730001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    32 Rushvale Road
    Ballyclare
    BT39 9NN Co Antrim
    Administrateur
    32 Rushvale Road
    Ballyclare
    BT39 9NN Co Antrim
    Northern IrelandBritishChief Executive75236310001
    SMYTH, Noel
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    Sandyford
    Co Dublin
    Administrateur
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    Sandyford
    Co Dublin
    IrishDirector143626320001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brunswick (No 1) Limited
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementNorthern Ireland
    Autorité légaleCompanies Act Ni
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrementNi42923
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BRUNSWICK (6 LANYON PLACE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 05 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Mortgage debenture - all monies. First the lands and premises comprised in folio AN90304L county antrim and known as lanyon car park, lanyon place belfast. Second the lands and premises comprised in folio AN47471 county antrim known as hilton car park, langon place belfast.. Third all that and those the land and premises situate at and known as 9 lanyon place, belfast being such parts of the lands comprised in folios AN26373, AN27408, AN28638, AN33166 and AN44154 county antrim. But with the benefit of undertlease dated 7 june 2001, to be registered in the land registry under folio number AN138244L county antrim.. Fourth the lands and premises known as 36/38 donegall place, belfast comprised in folio AN99613 county antrim.. Fifth the lands and premises known as 9/15 bedford street, belfast comprised in folio AN141191 county antrim.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 14 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Mortgage / charge - all monies. All that and those the land and premises situate at and known as 9 lanyon place, belfast being such parts of the lands comprised in folios AN26373, AN27408, AN28638, AN33166 and AN44154 .
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 14 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Assignment of rental income - all monies. All that and those the land and premises situate at and known as 9 lanyon place, belfast, county borough of belfast.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 14 févr. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 20 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    To the intent that the bank shall have a security or interests in the collateral as security for the secured liabilities, the company hereby:. (I) assigns its collateral, the beneficial interest and all other rights of the company in the collateral, including without limitation all dividends and distributions, interest and income and returns of contributions payable in respect thereof, to the bank, provided that until such time as an event of default has occured, all payments of income arising in relation to the collateral shall continue to be paid to the bank by the trustee;. (Ii) agrees that, to the extent that the company shall not have assigned to the bank or perfected in its favour, title to any of the affected securities, the bank (and/or some other person chosen by the bank to act on its behalf) shall have posscession of certificates of title thereto;.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 18 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 20 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Deed of assignment of rent - all monies. The deposit and the rental income and all the company's right title and interest in the deposit and the rental income to the bank by way of first fixed charge and as beneficial owner as a continuing security for the payment and discharge in full of the secured liabilities.. The schedule. All that freehold property known as 12 and 14 donegall place, belfast...........
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 18 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 02 août 2005
    Livré le 05 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage/charge. The freehold land and premises situate at and known as windsor house, numbers nine to fifteen bedford street, eight to twelve james street south and thirty one to forty one franklin street belfast in the county of belfast...........................................
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 05 août 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 02 août 2005
    Livré le 05 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Assignment of rental income supplemental to mortgage dated 2ND august 2005 granted by the company in favour of the bank in respect of premises at windsor house belfast.. The property being all that and those the land and premises situate and known as windsor house, 9-15 bedford street, 8-12 james street south and thirty 31/41 franklin street belfast......................................................................
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 05 août 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 16 mars 2004
    Livré le 22 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies deed of charge all existing security at any time given by the company to anglo irsh bank corporation PLC.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank
    Transactions
    • 22 mars 2004Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 22 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 31 juil. 2003
    Livré le 01 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage all that and those the premises now known as numbers 36 and 38 donegall pl. In the city parish and barony of belfast ........................................ see doc 37 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Belfast
    • Anglo Irish Bank
    Transactions
    • 01 août 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 19 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage/charge. 1. (1) the mortgagor (to the intent that the security hereby created shall rank as a continuing security in favour of the bank) as security for the payment and discharge of the secured obligations as beneficial owner hereby: see doc 36 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    • Belfast
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 01 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 07 mai 2003
    Livré le 21 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies legal charge. All that and those the lands comprised in folio an 47471 co. Antrim.
    Personnes ayant droit
    • Belfast
    • 14/18 Great Victoria
    • Anglo Irish Bank
    Transactions
    • 21 mai 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 22 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 mars 2003
    Livré le 28 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies floating charge. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. See doc 32 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank
    • 14/18 Great Victoria
    • Belfast
    Transactions
    • 28 mars 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 18 janv. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 25 mars 2003
    Livré le 28 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies legal charge. All that and those the lands comprised in folio an 90304L co. Antrim.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank
    • 14/18 Great Victoria
    • Belfast
    Transactions
    • 28 mars 2003Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 22 août 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage or charge
    Créé le 28 juin 2002
    Livré le 10 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies debenture. First all that and those the land and premises situate at and known as 6 lanyon place, belfast being part of the lands in the above numbered folio AN33166 shown coloured brown on the map attached to the agreement............... ........................................ see doc 19 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    • East, Belfast
    Transactions
    • 10 juil. 2002Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 20 nov. 2000
    Livré le 21 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies. Security agreement. By way of first fixed charge: all its estate or interest in all freehold or leasehold property...... "All that part of the lands in the above numbered folio an 33166 shown coloured brown on the map attached to the agreement for lease situated at east bridge street in the county borough of belfast known as site 5, lanyon place, belfast see doc 7 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 21 nov. 2000Enregistrement d'une charge (402 NI)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0