ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | NI040937 |
Juridiction | Irlande du Nord |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2023 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2024 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 juin 2024 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 19 juin 2024 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 05 juin 2023 |
En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de solvabilité | 4 pages | 4.71(NI) | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur | 1 pages | VL1 | ||||||||||
Notification de Iss Brightspark Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 déc. 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 09 nov. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 1 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Joanne Roberts en tant qu'administrateur le 22 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruce Andrew Van Der Waag en tant que directeur le 22 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephanie Louise Hamilton en tant que directeur le 31 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Ms Elizabeth Michelle Benison en tant qu'administrateur le 21 mai 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Stephanie Louise Hamilton en tant qu'administrateur le 22 févr. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip John Leigh en tant que directeur le 28 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Purvin Kumar Madhusudan Patel en tant que directeur le 23 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 1 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Purvin Kumar Madhusudan Patel en tant qu'administrateur le 16 juin 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Edward Stanley Brabin en tant que directeur le 16 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENISON, Elizabeth Michelle | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Executive Officer | 283639230001 | ||||
ROBERTS, Joanne | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Financial Officer | 288956810001 | ||||
BRABIN, Matthew | Secrétaire | Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Genesis Business Park Surrey England | 194364800001 | |||||||
CHANDLER, Edward Charles | Secrétaire | Orchard Cottage Poole CW5 6AP Nantwich Cheshire | British | 106101920001 | ||||||
DAVIDSON, Ian | Secrétaire | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | 146938000001 | |||||||
SIMONS, David Thomas | Secrétaire | 8 Rowley Hall Drive Rowley Hall Drive ST17 9FF Stafford | British | 74951460001 | ||||||
BRABIN, Matthew Edward Stanley | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Executive Officer | 92458830002 | ||||
BRABIN, Matthew Edward Stanley | Administrateur | Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Genesis Business Park Surrey England | England | British | Director | 92458830002 | ||||
CHANDLER, Edward Charles | Administrateur | Orchard Cottage Poole CW5 6AP Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 106101920001 | ||||
CLARKE, Clive | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | Northern Ireland | Irish | Director | 144506380001 | ||||
COTTAM, Paul Andrew | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | United Kingdom | British | Director | 318127910001 | ||||
CROOK, Ian Kenneth | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Director | 149496650001 | ||||
DAVIDSON, Ian | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Director | 127506640001 | ||||
HAMILTON, Stephanie Louise | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | United Kingdom | British | Head People & Culture | 280463790001 | ||||
KIDD, Gary John | Administrateur | Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Genesis Business Park Surrey England | United Kingdom | British | Director | 190462280001 | ||||
LEIGH, Philip John | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Operating Officer | 156680600002 | ||||
PATEL, Purvin Kumar Madhusudan | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Executive Officer | 271205360001 | ||||
PLUCNAR JENSEN, Barbara | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | Danish | Chief Financial Officer | 216409100001 | ||||
REYNOLDS, Jamie | Administrateur | 21 Birchgate Grove Bucknall ST2 8JU Stoke On Trent Staffordshire, England | British | Director | 134543360001 | |||||
RILEY, Christopher Paul | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | British | Chief Operating Officer | 171492980001 | ||||
SIMONS, David Thomas | Administrateur | 8 Rowley Hall Drive Rowley Hall Park ST17 9FF Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 74951460001 | ||||
SYKES, Richard Ian | Administrateur | Albert Drive GU21 5RW Woking Iss House Genesis Business Park Surrey England | United Kingdom | British | Director | 93113770004 | ||||
TAYLOR, Raymond | Administrateur | 10 Sandeel Lane Orloack BT19 6LP Groomsport | British | Director | 144506350001 | |||||
TENNENT, Colin Robert | Administrateur | 69a Main Road Goostrey CW4 8JR Crewe Cheshire | England | British | Group Chief Executive Offficer | 23661940005 | ||||
VAN DER WAAG, Bruce Andrew | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | England | Dutch | Chief Financial Officer | 195067340001 | ||||
VESTERGAARD, Jorn | Administrateur | Unit 1a Portside Business Park Airport Road West BT3 9ED Belfast | United Kingdom | Danish | Cfo | 198906050001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iss Brightspark Limited | 18 déc. 2023 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Iss Technical Services Limited | 06 avr. 2016 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Northern irish debenture | Créé le 05 juil. 2012 Livré le 13 juil. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Northern irish debenture | Créé le 03 mars 2010 Livré le 05 mars 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 1.1 by way of mortgage all that and those the company's freehold and leasehold lands, hereditaments, premises, property and all chattels both present at the date of the debenture and future, including, without prejudice to the generality of the foregoing, the property, particulars of which are specified in the schedule hereto...see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
ISS TECHNICAL SERVICES NI LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0