SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED

SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI043239
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Millennium House
    25 Great Victoria Street
    BT2 7AQ Belfast
    Northern Ireland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIRTRICITY HOLDINGS (UK) LIMITED17 mai 200217 mai 2002

    Quels sont les derniers comptes de SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au16 janv. 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation30 janv. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au16 janv. 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2026 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2025

    26 pagesAA

    legacy

    288 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Cessation de la nomination de Daniel Mark Pearson en tant que directeur le 21 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kate Johanna Wallace Lockhart en tant que directeur le 19 sept. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Gerald Cooley en tant que directeur le 27 août 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Andrew Wilson en tant qu'administrateur le 27 août 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alexandra Leta Malone en tant que directeur le 07 juil. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Kerry Stacey Berry en tant qu'administrateur le 03 mars 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Kate Johanna Wallace Lockhart en tant qu'administrateur le 03 mars 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Gayle Catherine Hill en tant qu'administrateur le 03 mars 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2024

    26 pagesAA

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    344 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Stuart Peter Hood en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Jane Elizabeth Dunne en tant qu'administrateur le 14 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Robert Bryce en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Heather Lindsay Donald en tant qu'administrateur le 01 sept. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Finlay Alexander Mccutcheon en tant que directeur le 17 mai 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Rosalind Futter en tant qu'administrateur le 17 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    O'CONNOR, Bernard Michael
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Secrétaire
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    261240570001
    BERRY, Kerry Stacey
    G2 6AY Glasgow
    1 Waterloo Street
    Scotland
    Administrateur
    G2 6AY Glasgow
    1 Waterloo Street
    Scotland
    EnglandBritish333007370001
    BRYCE, Robert
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish326688520001
    DONALD, Heather Lindsay
    G2 6AY Glasgow
    1 Waterloo Street
    Scotland
    Administrateur
    G2 6AY Glasgow
    1 Waterloo Street
    Scotland
    ScotlandBritish326675940001
    DUNNE, Jane Elizabeth
    South County Business Park, Leopardstown
    D18 W688 Dublin 18
    Red Oak South
    Ireland
    Administrateur
    South County Business Park, Leopardstown
    D18 W688 Dublin 18
    Red Oak South
    Ireland
    IrelandIrish328167650001
    FUTTER, Rosalind Charlotte, Mrs.
    Buckingham Palace Road
    SW1W 0SR London
    111
    England
    Administrateur
    Buckingham Palace Road
    SW1W 0SR London
    111
    England
    EnglandBritish318544890001
    HILL, Gayle Catherine
    AB16 5NW Aberdeen
    200 Ashgrove West
    Scotland
    Administrateur
    AB16 5NW Aberdeen
    200 Ashgrove West
    Scotland
    ScotlandBritish333007360001
    HOOD, Stuart Peter
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish329647650001
    WHEELER, Stephen
    South County Business Park
    Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    Administrateur
    South County Business Park
    Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    IrelandIrish143540290003
    WILSON, Steven Andrew
    G2 6AY Glasgow
    One Waterloo Street
    Scotland
    Administrateur
    G2 6AY Glasgow
    One Waterloo Street
    Scotland
    ScotlandBritish323678250001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Secrétaire
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    165186920001
    FAIRBAIRN, Sally
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Secrétaire
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    193203950001
    CRESCENT TRUST CO
    One Spencer Dock
    North Wall Quay
    Dublin 1
    Ireland
    Secrétaire
    One Spencer Dock
    North Wall Quay
    Dublin 1
    Ireland
    142967980001
    CS CYPHER SERVICES LIMITED
    50 Bedford Street
    Belfast
    BT2 7FW
    Secrétaire
    50 Bedford Street
    Belfast
    BT2 7FW
    142967990001
    ALEXANDER, Fraser Mcgregor
    200
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    United Kingdom
    Administrateur
    200
    Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    United Kingdom
    United KingdomBritish65278040002
    BAKER, Alan
    16 Harbourside Kip Village
    Inverkip
    PA16 0BF
    Administrateur
    16 Harbourside Kip Village
    Inverkip
    PA16 0BF
    ScotlandScottish103351610001
    COOLEY, Paul Gerald
    Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1
    Scotland
    Administrateur
    Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1
    Scotland
    ScotlandIrish193554150002
    COWIE, Steve
    34 Divert Road
    Gourock
    PA19 1DT
    Administrateur
    34 Divert Road
    Gourock
    PA19 1DT
    English142968050001
    DONALDSON, Peter Symons
    PH16 5NF Pitlochry
    Clunie Power Station
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    PH16 5NF Pitlochry
    Clunie Power Station
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131456210001
    DOWLING, Paul Cyril
    Weston, Carrick Brook
    Eadestown
    Naas
    County Kildare
    Administrateur
    Weston, Carrick Brook
    Eadestown
    Naas
    County Kildare
    IrelandIrish111811130002
    DOWNES, John Anthony
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish116885490002
    DWYER, Nicola
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin
    Airtricity House
    18
    Ireland
    Administrateur
    Ravenscourt Office Park
    Sandyford
    Dublin
    Airtricity House
    18
    Ireland
    IrelandIrish160281420001
    FITZGERALD, Louis
    32 Stillorgan Grove
    Blackrock
    Dublin
    Administrateur
    32 Stillorgan Grove
    Blackrock
    Dublin
    Irish142968060001
    FITZGERALD, Louis
    32 Stillorgan Grove
    Blackrock
    Dublin
    Administrateur
    32 Stillorgan Grove
    Blackrock
    Dublin
    Irish142968000001
    FLYNN, Donal Francis
    3 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    Dublin 14
    Administrateur
    3 Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    Dublin 14
    IrelandIrish126967800001
    GARDNER, David
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish126262860001
    GIBLIN, Caoimhe Mary
    South County Business Park
    Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    Administrateur
    South County Business Park
    Leopardstown
    18 Dublin
    Red Oak South
    Ireland
    IrelandIrish153460940001
    HARLEY, Elaine
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish267341500001
    HEYES, Simon Murray
    8 Turretbank Road
    Creiff
    PH7 4LN Perthshire
    Scotland
    Administrateur
    8 Turretbank Road
    Creiff
    PH7 4LN Perthshire
    Scotland
    United KingdomBritish189332050001
    HONEYMAN, Alexander Hughes
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    United KingdomBritish213163040002
    LAVERY, John
    Brugh Na Carraige
    Glenalua
    Killiney
    Dublin
    Administrateur
    Brugh Na Carraige
    Glenalua
    Killiney
    Dublin
    Irish142968070001
    MALONE, Alexandra Leta
    111 Buckingham Palace Road
    SW1W 0SR London
    Sse
    England
    Administrateur
    111 Buckingham Palace Road
    SW1W 0SR London
    Sse
    England
    EnglandBritish295018940001
    MCADAM, Martin
    35 Glen Lawn Drive, The Park
    Cabinteely, Dublin
    Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    35 Glen Lawn Drive, The Park
    Cabinteely, Dublin
    Dublin 18
    Ireland
    Irish142968100001
    MCCUTCHEON, Finlay Alexander
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish167444610002
    MCCUTCHEON, Finlay Alexander
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Inveralmond House
    Scotland
    ScotlandBritish167444610001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SSE RENEWABLES HOLDINGS (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    25 Great Victoria Street
    BT2 7AQ Belfast
    Millennium House
    Northern Ireland
    06 avr. 2016
    25 Great Victoria Street
    BT2 7AQ Belfast
    Millennium House
    Northern Ireland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementNorthern Ireland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Northern Ireland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementNi049557
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0