RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED

RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société NI043860
    JuridictionIrlande du Nord
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Official Receivers Office (Insolvency Service) Fermanagh House
    Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BIONETRICS LIMITED19 août 200219 août 2002

    Quels sont les derniers comptes de RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 sept. 2017
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2016
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination d'un liquidateur (judiciaire)

    1 pages4.32(NI)

    Changement d'adresse du siège social de 27-29 Gordon Street Belfast BT1 2LG à Official Receivers Office (Insolvency Service) Fermanagh House Ormeau Avenue Belfast County Antrim BT2 8NJ le 20 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    1 pagesCOCOMP

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 août 2015

    État du capital au 24 août 2015

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2014

    5 pagesAA

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2014

    État du capital au 19 août 2014

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2013

    État du capital au 19 août 2013

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Tanya Eleanor Waterworth le 19 août 2010

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Stephen Waterworth le 19 août 2010

    2 pagesCH01

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    4 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WATERWORTH, Tanya Eleanor
    93 Fort Road
    Ballylesson
    BT8 8LX Belfast
    Secrétaire
    93 Fort Road
    Ballylesson
    BT8 8LX Belfast
    145152880001
    WATERWORTH, Robert Stephen
    93 Fort Road
    Ballylesson
    BT8 8LX Belfast
    Administrateur
    93 Fort Road
    Ballylesson
    BT8 8LX Belfast
    Northern IrelandBritishBuilder145152900001
    PALMER, Robert Desmond
    31 Kilmaine Road
    Bangor
    BT19 6DT Co Down
    Administrateur
    31 Kilmaine Road
    Bangor
    BT19 6DT Co Down
    Northern IrelandBritishFormation Agent143255820001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Robert Stephen Waterworth
    Fermanagh House
    Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    Official Receivers Office (Insolvency Service)
    County Antrim
    06 avr. 2016
    Fermanagh House
    Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    Official Receivers Office (Insolvency Service)
    County Antrim
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Northern Ireland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 19 avr. 2010
    Livré le 20 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    612 saintfield road, belfast being all the lands comprised in folio 29964 county down.. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforementioned premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 20 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 107 mars 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 1
    Mortgage
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 09 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Development site (oaktree cottages) at nutts corner, crumlin, county antrim being all the lands comprised in folio AN157723 county antrim. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforementioned premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 09 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 05 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Development site to the rear of comber orange hall, comber, county down being all the lands comprised in folio DN156230 county down. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforementioned premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 05 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 05 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    10 maghaberry road, moira, county antrim being all the lands comprised in folios 6728L county antrim and an 129508L county antrim. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforementioned premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 05 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage or charge
    Créé le 14 juin 2008
    Livré le 26 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. 35A-41 glenbank place, belfast under folio AN157284L co antrim.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 26 juin 2008Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 327 oct. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 3
    Mortgage or charge
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 23 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. 610 saintfield road, carryduff, belfast in all the lands in folio 33520 co down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 23 juin 2008Enregistrement d'une charge (402R NI)
    • 203 avr. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Mortgage or charge
    Créé le 17 déc. 2007
    Livré le 07 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. Plot of ground at 96 ballymacash road, lisburn comprised in folio AN9256 co antrim.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 07 janv. 2008Enregistrement d'une charge (402R NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 06 nov. 2007
    Livré le 14 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. 8 nutts corner road, crumlin BT29 4BW.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2007Enregistrement d'une charge (402R NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 16 oct. 2007
    Livré le 06 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. Premises known as 608 saintfield road, carryduff being the premises contained in folio 33067 county down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 06 nov. 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 01 oct. 2007
    Livré le 09 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies solicitors' undertaking. 10 maghaberry road, maghaberry.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 09 oct. 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 14 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage or charge
    Créé le 15 août 2007
    Livré le 30 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies mortgage. Lands at 1 drumbeg cottages, ballyskeagh road, drumbeg comprised in DN133775L co down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 30 août 2007Enregistrement d'une charge (402R NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 22 mai 2007
    Livré le 25 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies solicitors' undertaking. Site at woodland drive, lambeg, lisburn.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 25 mai 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 24 avr. 2007
    Livré le 27 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies solicitors' undertaking. Lands to the rear of comber orange hall, railway street, comber, co. Down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 27 avr. 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    • 07 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 22 janv. 2007
    Livré le 29 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies solicitors' undertaking. 96 ballymacash road, lisburn.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2007Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 27 nov. 2006
    Livré le 05 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    All monies solicitors' undertaking. Factory premises at glenbank place, ballysillan road, belfast.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 05 déc. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 08 juin 2006
    Livré le 16 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Property being at 608 saintfield road, carryduff, county down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 16 juin 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 05 juin 2006
    Livré le 20 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Development site at nutts corner road, crumlin.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 20 juin 2006Enregistrement d'une charge (402R NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 24 mars 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Site at 612 saintfield road, belfast over folio 29964 co. Down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 22 févr. 2006
    Livré le 28 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Site at grace avenue, belfast.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 21 févr. 2006
    Livré le 01 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Company mortgage and charge - all monies. Lands at 31 benson street, lisburn, county antrim being the lands comprised in folio AN130274 county antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 01 mars 2006Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 22 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors undertaking - all monies. Site at maymount street, woodstock road, belfast.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 22 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Floating charge - all monies. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. N.B. the company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern ireland limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets......see 402 for further details..
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Mortgage or charge
    Créé le 22 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Charge over all book debts - all monies. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 30 août 2005
    Livré le 20 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Land at ballyhalbert road, crawfordsburn, county antrim.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 20 sept. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)
    Solicitors letter of undertaking
    Créé le 30 août 2005
    Livré le 20 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    0
    Brèves mentions
    Solicitors' undertaking - all monies. Land at antrim road, ballynahinch, county down.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 20 sept. 2005Enregistrement d'une charge (402 NI)

    RSW CONSTRUCTION (NI) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Frazer
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    Brian Kidd
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Frazer
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    Brian Kidd
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Frazer
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    Brian Kidd
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    receiver manager
    Telfair House 87-89 Victoria Street
    BT1 4PB Belfast
    Antrim
    4
    DateType
    17 nov. 2016Commencement of winding up
    05 sept. 2016Petition date
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ken Pattullo
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast
    practitioner
    Scottish Provident Building, 7 Donegall Square West
    BT1 6JH Belfast
    The Official Receiver Or Belfast
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim
    practitioner
    Fermanagh House Ormeau Avenue
    BT2 8NJ Belfast
    County Antrim

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0