CROWTHER BEARD LLP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCROWTHER BEARD LLP
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL)
    Numéro de société OC301792
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe CROWTHER BEARD LLP ?

    Adresse du siège social
    23 Russet Close
    WR2 6EL Worcester
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CROWTHER BEARD LLP ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CROWTHER BEARD LLP ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation19 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au05 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CROWTHER BEARD LLP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    XD5KUZ4Y

    Changement d'adresse du siège social de Sagger House Princes Drive Worcester WR1 2PG England à 23 Russet Close Worcester WR2 6EL le 19 juin 2024

    1 pagesLLAD01
    XD5KUXRD

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2023

    6 pagesAA
    XCZQ29QX

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    XC62FTMA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2022

    6 pagesAA
    XC62FQFE

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    XB5LJTAP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2021

    6 pagesAA
    XB4MYLKP

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    XA6WZIBN

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2020

    6 pagesAA
    XA6WZGKY

    Modification des détails de Mr Christopher John Hobbs en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 juin 2021

    2 pagesLLPSC04
    XA6WZEYY

    Modification des informations du membre pour Mr Christopher John Hobbs le 18 juin 2021

    2 pagesLLCH01
    XA6WZERT

    Changement d'adresse du siège social de Suite 1a Shire Business Park Wainwright Road Worcester Worcestershire WR4 9FA à Sagger House Princes Drive Worcester WR1 2PG le 18 juin 2021

    1 pagesLLAD01
    XA6WZECB

    Modification des informations du membre pour Mr John Harvey Painter le 15 mars 2021

    2 pagesLLCH01
    XA6WZCG1

    Modification des détails de Mr John Harvey Painter en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 mars 2021

    2 pagesLLPSC04
    XA6WZBHS

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    X98W4Q62

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2019

    9 pagesAA
    X9881M4P

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018

    11 pagesAA
    X87DAPZK

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    X87DAMTK

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2018 au 30 sept. 2018

    1 pagesLLAA01
    X7L0SQ6Y

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01
    X77GOOY3

    Satisfaction de charge OC3017920013 en totalité

    1 pagesLLMR04
    X733FGCQ

    Satisfaction de charge OC3017920014 en totalité

    1 pagesLLMR04
    X733FPX6

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    8 pagesAA
    A6LSQ9YW

    Déclaration de confirmation établie le 05 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesLLCS01
    X6854E2J

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA
    A5MF241F

    Qui sont les dirigeants de CROWTHER BEARD LLP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOBBS, Christopher John
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Sagger House
    England
    Membre désigné de la LLP
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Sagger House
    England
    England64176200001
    PAINTER, John Harvey
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Saggar House
    Worcestershire
    England
    Membre désigné de la LLP
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Saggar House
    Worcestershire
    England
    England20232210002
    BEARD, Richard Frank
    Burleigh Old Church Road
    Colwall
    WR13 6EZ Malvern
    Membre désigné de la LLP
    Burleigh Old Church Road
    Colwall
    WR13 6EZ Malvern
    England175369780001
    COSTELLO-BYRNE, Sarah Elizabeth
    Suite 1a Shire Business Park
    Wainwright Road
    WR4 9FA Worcester
    Worcestershire
    Membre désigné de la LLP
    Suite 1a Shire Business Park
    Wainwright Road
    WR4 9FA Worcester
    Worcestershire
    United Kingdom97500070002
    CROWTHER, Jonathan James
    34 Lanesfield Park
    Greenhill
    WR11 4NU Evesham
    Membre désigné de la LLP
    34 Lanesfield Park
    Greenhill
    WR11 4NU Evesham
    141218430001
    JONES, Margaret Helen
    52 Fruitlands
    WR14 4XA Malvern
    Membre désigné de la LLP
    52 Fruitlands
    WR14 4XA Malvern
    England69740330001
    MORGAN, Thomas Robert
    29 Iron Way
    B60 3GN Bromsgrove
    Membre désigné de la LLP
    29 Iron Way
    B60 3GN Bromsgrove
    United Kingdom150460190001
    WATKINS, David Edgar Lawrence
    The Redgate
    32 Avenue Road
    WR14 3BJ Malvern
    Membre de la LLP
    The Redgate
    32 Avenue Road
    WR14 3BJ Malvern
    79028990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CROWTHER BEARD LLP ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr John Harvey Painter
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Saggar House
    Worcestershire
    England
    01 juin 2016
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Saggar House
    Worcestershire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la LLP.
    • La personne détient ou est réputée détenir, directement ou indirectement, le droit de participer à plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actifs excédentaires de la LLP en cas de liquidation.
    Mr Christopher John Hobbs
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Sagger House
    England
    01 juin 2016
    Princes Drive
    WR1 2PG Worcester
    Sagger House
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la LLP.
    • La personne détient ou est réputée détenir, directement ou indirectement, le droit de participer à plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actifs excédentaires de la LLP en cas de liquidation.

    CROWTHER BEARD LLP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 déc. 2013
    Livré le 13 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Unit 1A shire business park, wainwright road, worcester; and. 1A church road, tewkesbury. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Oldfield Business Services Limited
    Transactions
    • 13 déc. 2013Enregistrement d'une charge (LLMR01)
    • 03 avr. 2018Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    A registered charge
    Créé le 04 déc. 2013
    Livré le 05 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    As a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges to the chargee by way of fixed charge:. (A) all properties acquired by the chargor in the future;. (B) all present and future interests of the chargor not effectively mortgaged or charged under the preceding provisions of this clause 3 in, or over, freehold or leasehold property;. (C) all present and future rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties relating to each property;. (D) all licences, consents and authorisations (statutory or otherwise) held or required in connection with the chargor's business or the use of any secured asset, and all rights in connection with them;. (E) all its present and future goodwill;. (F) all its uncalled capital;. (G) all the equipment;. (H) all intellectual property;. (I) all the book debts;. (J) all monies from time to time standing to the credit of its accounts with any bank, financial institution or other person (including each designated account).. As a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges to the chargee, by way of a floating charge, all the undertaking, property, assets and rights of the chargor at any time not effectively mortgaged, charged or assigned pursuant to clause 3.1 to clause 3.6 inclusive.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nicklin LLP
    Transactions
    • 05 déc. 2013Enregistrement d'une charge (LLMR01)
    • 03 avr. 2018Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Debenture
    Créé le 27 juil. 2009
    Livré le 04 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2009Enregistrement d'une charge (LLP395)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 05 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Standard life policy number X50275365 date 11/04/2001 sum £100,000 life assured christopher john hobbs together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 05 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Standard life policy number X50275278 date 11/04/2001 sum £100,000 life assured jonathan james crowther together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 05 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Standard life policy number X50275251 date 11/04/2001 sum £100,000 life assured john harvey painter together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Debenture
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 13 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Debenture
    Créé le 12 août 2002
    Livré le 20 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0