THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP
Vue d'ensemble
Nom de la société | THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
Numéro de société | OC302755 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?
Adresse du siège social | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow Middlesex |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 05 avr. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société à responsabilité limitée du registre du commerce | 2 pages | LLDS01 | ||
Cessation de la nomination de Susan Garrard en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Christopher David Winfield en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Shaun Michael Wyles en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew James Willoughby en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Augustus Warren en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Hugh Mark Warrender en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Oliver Thorold en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Hugh Ian Taylor en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Steven Paul Sharp en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Stephen Edward Ryan en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Paris Moayedi en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de John Henry King en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Ashley John King en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Philip Alexander Mastriforte en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Charles Hodson en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Gutteridge en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Jason Fearon en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Raymond Charles Eyre en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Rupert Alexander Lendon English en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Valerie Josephine Bradley en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Rajesh Kumar Bhardwaj en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Arthur Dove en tant que membre le 22 mars 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVICTA FILM NOMINEES LIMITED | Membre désigné de la LLP | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow |
| 141180010001 | ||||||||||
SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED | Membre désigné de la LLP | 99 Kenton Road HA3 0AN Harrow |
| 141180020001 | ||||||||||
BHARDWAJ, Rajesh Kumar | Membre de la LLP | Hardingwood Lodge Hardingwood Lane Fillongley CV7 8EL Coventry | England | 66071000002 | ||||||||||
BRADLEY, Ian George | Membre de la LLP | Kingston House Kingston Lane West Kingston Farm BN16 1RP East Preston | United Kingdom | 141468400001 | ||||||||||
BRADLEY, Valerie Josephine | Membre de la LLP | Kingston House W Kingston Farm Kingston Lane BN16 1RP East Preston | England | 33286510002 | ||||||||||
DAVIES, Michael Dudley Moran | Membre de la LLP | Westcott Lodge 22 Lower Mall W6 9DJ London | United Kingdom | 141468630001 | ||||||||||
DOVE, Anthony Arthur | Membre de la LLP | Horsted Lane Isfield TN22 5TX East Sussex Filsham Lodge | United Kingdom | 141447800001 | ||||||||||
ENGLISH, Rupert Alexander Lendon | Membre de la LLP | 21 Aylestone Avenue NW6 7AE London | United Kingdom | 141468440001 | ||||||||||
EYRE, Raymond Charles | Membre de la LLP | 79 Addison Road Holland Park W14 8ED London | England | 44367560006 | ||||||||||
FEARON, Andrew Jason | Membre de la LLP | Brooms Langley Lower Green CB11 4SB Saffron Walden | United Kingdom | 69281370002 | ||||||||||
GARRARD, Susan | Membre de la LLP | Dudley Wood Dullingham Road CB8 9JT Newmarket | United Kingdom | 141447860001 | ||||||||||
GUTTERIDGE, Stephen | Membre de la LLP | Silverwood Lunghurst Road, Woldingham CR3 7EG Caterham | England | 55082060001 | ||||||||||
HODSON, Andrew Charles | Membre de la LLP | Little Orchard Snow End, Anstey SG9 0BZ Buntingford | United Kingdom | 141447810001 | ||||||||||
KING, Ashley John | Membre de la LLP | Tudor Lodge Fen Road Holbeach PE12 8QD Spalding | England | 155911910002 | ||||||||||
KING, John Henry, The Estate Of | Membre de la LLP | Holbeach Manor Fleet Road Holbeach PE12 7AX Spalding | United Kingdom | 7444250001 | ||||||||||
MASTRIFORTE, Philip Alexander | Membre de la LLP | Anderson Street SW3 3LU London 1 | England | 62802350005 | ||||||||||
MOAYEDI, Paris | Membre de la LLP | The Old House Bridge Green Duddenhoe End CB11 4XA Saffron Walden | England | 2646590001 | ||||||||||
PAMPLIN, Robert David | Membre de la LLP | 40 Lamont Road SW10 0JA London | United Kingdom | 113539290001 | ||||||||||
RYAN, Mark Stephen Edward | Membre de la LLP | The Old Hall Little Heath Road CH3 7AH Christleton | United Kingdom | 142752190001 | ||||||||||
SHARP, Steven Paul | Membre de la LLP | 1 Carlton Hill St Johns Wood NW8 0JX London | England | 94187980002 | ||||||||||
TAYLOR, Hugh Ian | Membre de la LLP | 26 Queens Gate Place Mews SW7 5BQ London | United Kingdom | 141280570001 | ||||||||||
THOROLD, Anthony Oliver | Membre de la LLP | 8 Richmond Crescent N1 0LZ London | United Kingdom | 141447850003 | ||||||||||
WARREN, Paul Augustus | Membre de la LLP | 1 Maidstone Road DA14 5RH Sidcup River House Kent | United Kingdom | 141327440001 | ||||||||||
WARRENDER, Hugh Mark | Membre de la LLP | c/o Ian Hallums Copse Edge Avenue KT17 4HS Epsom 20 | United Kingdom | 141468380002 | ||||||||||
WILLOUGHBY, Andrew James | Membre de la LLP | Clenemer Cottage Village Road HP7 0LH Coleshill | England | 48650020002 | ||||||||||
WINFIELD, Christopher David | Membre de la LLP | Hormead Cottage Great Hormead SG9 0NR Buntingford | United Kingdom | 141447870002 | ||||||||||
WYLES, Shaun Michael | Membre de la LLP | Osbrooks Horsham Road Capel RH5 5JN Dorking | England | 141468370001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
26 sept. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A charge and deed of assignment | Créé le 29 juin 2004 Livré le 08 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The deposit and all the entitlements to interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A charge and deed of assignment | Créé le 23 juin 2004 Livré le 02 juil. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any of the partners to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The security account and the deposit and all entitlements to interest the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A charge and deed of assignment | Créé le 18 juin 2004 Livré le 25 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The security account and the deposit and all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. All right and interest in and to the benefit of the lease agreement and all right title and interest in and to the benefit of the guarantee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Assignment and charge | Créé le 05 avr. 2004 Livré le 16 avr. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The delivery material being 35MM original picture negative of the final conformed film without defects containing english main and end titles fully edited and finalised by the production company as approved at the answer print stage; and 35MM dolby sr soundtrack negative which is in synchronisation with the above picture negative and conformed with dolby sr soundtrack of the english version. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over cash deposit and account and deed of assignment | Créé le 27 nov. 2003 Livré le 11 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The deposit and all the entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. By way of security all of its right title and interest in and to the benefit of the lease agreement and all of its right title and interest in and to the benefit of the guarantee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0