THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL)
    Numéro de société OC302755
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?

    Adresse du siège social
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société à responsabilité limitée du registre du commerce

    2 pagesLLDS01

    Cessation de la nomination de Susan Garrard en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Christopher David Winfield en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Shaun Michael Wyles en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew James Willoughby en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Paul Augustus Warren en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Hugh Mark Warrender en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Oliver Thorold en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Hugh Ian Taylor en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Steven Paul Sharp en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Mark Stephen Edward Ryan en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Paris Moayedi en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de John Henry King en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Ashley John King en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Philip Alexander Mastriforte en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Charles Hodson en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Gutteridge en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Jason Fearon en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Raymond Charles Eyre en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Rupert Alexander Lendon English en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Valerie Josephine Bradley en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Rajesh Kumar Bhardwaj en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Arthur Dove en tant que membre le 22 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Qui sont les dirigeants de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Membre désigné de la LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Membre désigné de la LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4244204
    141180020001
    BHARDWAJ, Rajesh Kumar
    Hardingwood Lodge
    Hardingwood Lane Fillongley
    CV7 8EL Coventry
    Membre de la LLP
    Hardingwood Lodge
    Hardingwood Lane Fillongley
    CV7 8EL Coventry
    England66071000002
    BRADLEY, Ian George
    Kingston House
    Kingston Lane West Kingston Farm
    BN16 1RP East Preston
    Membre de la LLP
    Kingston House
    Kingston Lane West Kingston Farm
    BN16 1RP East Preston
    United Kingdom141468400001
    BRADLEY, Valerie Josephine
    Kingston House W Kingston Farm
    Kingston Lane
    BN16 1RP East Preston
    Membre de la LLP
    Kingston House W Kingston Farm
    Kingston Lane
    BN16 1RP East Preston
    England33286510002
    DAVIES, Michael Dudley Moran
    Westcott Lodge
    22 Lower Mall
    W6 9DJ London
    Membre de la LLP
    Westcott Lodge
    22 Lower Mall
    W6 9DJ London
    United Kingdom141468630001
    DOVE, Anthony Arthur
    Horsted Lane
    Isfield
    TN22 5TX East Sussex
    Filsham Lodge
    Membre de la LLP
    Horsted Lane
    Isfield
    TN22 5TX East Sussex
    Filsham Lodge
    United Kingdom141447800001
    ENGLISH, Rupert Alexander Lendon
    21 Aylestone Avenue
    NW6 7AE London
    Membre de la LLP
    21 Aylestone Avenue
    NW6 7AE London
    United Kingdom141468440001
    EYRE, Raymond Charles
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    Membre de la LLP
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    England44367560006
    FEARON, Andrew Jason
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    Membre de la LLP
    Brooms
    Langley Lower Green
    CB11 4SB Saffron Walden
    United Kingdom69281370002
    GARRARD, Susan
    Dudley Wood
    Dullingham Road
    CB8 9JT Newmarket
    Membre de la LLP
    Dudley Wood
    Dullingham Road
    CB8 9JT Newmarket
    United Kingdom141447860001
    GUTTERIDGE, Stephen
    Silverwood
    Lunghurst Road, Woldingham
    CR3 7EG Caterham
    Membre de la LLP
    Silverwood
    Lunghurst Road, Woldingham
    CR3 7EG Caterham
    England55082060001
    HODSON, Andrew Charles
    Little Orchard
    Snow End, Anstey
    SG9 0BZ Buntingford
    Membre de la LLP
    Little Orchard
    Snow End, Anstey
    SG9 0BZ Buntingford
    United Kingdom141447810001
    KING, Ashley John
    Tudor Lodge
    Fen Road Holbeach
    PE12 8QD Spalding
    Membre de la LLP
    Tudor Lodge
    Fen Road Holbeach
    PE12 8QD Spalding
    England155911910002
    KING, John Henry, The Estate Of
    Holbeach Manor
    Fleet Road Holbeach
    PE12 7AX Spalding
    Membre de la LLP
    Holbeach Manor
    Fleet Road Holbeach
    PE12 7AX Spalding
    United Kingdom7444250001
    MASTRIFORTE, Philip Alexander
    Anderson Street
    SW3 3LU London
    1
    Membre de la LLP
    Anderson Street
    SW3 3LU London
    1
    England62802350005
    MOAYEDI, Paris
    The Old House
    Bridge Green Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    Membre de la LLP
    The Old House
    Bridge Green Duddenhoe End
    CB11 4XA Saffron Walden
    England2646590001
    PAMPLIN, Robert David
    40 Lamont Road
    SW10 0JA London
    Membre de la LLP
    40 Lamont Road
    SW10 0JA London
    United Kingdom113539290001
    RYAN, Mark Stephen Edward
    The Old Hall
    Little Heath Road
    CH3 7AH Christleton
    Membre de la LLP
    The Old Hall
    Little Heath Road
    CH3 7AH Christleton
    United Kingdom142752190001
    SHARP, Steven Paul
    1 Carlton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JX London
    Membre de la LLP
    1 Carlton Hill
    St Johns Wood
    NW8 0JX London
    England94187980002
    TAYLOR, Hugh Ian
    26 Queens Gate Place Mews
    SW7 5BQ London
    Membre de la LLP
    26 Queens Gate Place Mews
    SW7 5BQ London
    United Kingdom141280570001
    THOROLD, Anthony Oliver
    8 Richmond Crescent
    N1 0LZ London
    Membre de la LLP
    8 Richmond Crescent
    N1 0LZ London
    United Kingdom141447850003
    WARREN, Paul Augustus
    1 Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    River House
    Kent
    Membre de la LLP
    1 Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    River House
    Kent
    United Kingdom141327440001
    WARRENDER, Hugh Mark
    c/o Ian Hallums
    Copse Edge Avenue
    KT17 4HS Epsom
    20
    Membre de la LLP
    c/o Ian Hallums
    Copse Edge Avenue
    KT17 4HS Epsom
    20
    United Kingdom141468380002
    WILLOUGHBY, Andrew James
    Clenemer Cottage
    Village Road
    HP7 0LH Coleshill
    Membre de la LLP
    Clenemer Cottage
    Village Road
    HP7 0LH Coleshill
    England48650020002
    WINFIELD, Christopher David
    Hormead Cottage
    Great Hormead
    SG9 0NR Buntingford
    Membre de la LLP
    Hormead Cottage
    Great Hormead
    SG9 0NR Buntingford
    United Kingdom141447870002
    WYLES, Shaun Michael
    Osbrooks
    Horsham Road Capel
    RH5 5JN Dorking
    Membre de la LLP
    Osbrooks
    Horsham Road Capel
    RH5 5JN Dorking
    England141468370001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    26 sept. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.13, LLP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A charge and deed of assignment
    Créé le 29 juin 2004
    Livré le 08 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit and all the entitlements to interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 08 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2021Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    A charge and deed of assignment
    Créé le 23 juin 2004
    Livré le 02 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the partners to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The security account and the deposit and all entitlements to interest the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 02 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2021Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    A charge and deed of assignment
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 25 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The security account and the deposit and all entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. All right and interest in and to the benefit of the lease agreement and all right title and interest in and to the benefit of the guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 25 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2021Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Assignment and charge
    Créé le 05 avr. 2004
    Livré le 16 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The delivery material being 35MM original picture negative of the final conformed film without defects containing english main and end titles fully edited and finalised by the production company as approved at the answer print stage; and 35MM dolby sr soundtrack negative which is in synchronisation with the above picture negative and conformed with dolby sr soundtrack of the english version. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Columiba Pictures/U.K. Layer Cake Productions, Llc
    Transactions
    • 16 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over cash deposit and account and deed of assignment
    Créé le 27 nov. 2003
    Livré le 11 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit and all the entitlements to interest, the right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. By way of security all of its right title and interest in and to the benefit of the lease agreement and all of its right title and interest in and to the benefit of the guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Republic Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 11 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mars 2021Satisfaction d'une charge (LLMR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0