ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (SARL) |
| Numéro de société | OC305876 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Adresse du siège social | C/O Turcan Connell 12 Stanhope Gate W1K 1AW London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 05 avr. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Notification de Headstart Advertising Pvt Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 oct. 2021 | 2 pages | LLPSC02 | ||
Cessation de Scotts Film Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2021 | 1 pages | LLPSC07 | ||
Cessation de la nomination de Peter Glenn Sellars en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Christian Peter David Vine en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Jonathan Wiles en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Owen Stephen Skinner en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Tamas Vasary en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Bernard Solomon en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Premiere Film Services Limited en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Barry Neilson en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Steven Patrick Moriarty en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Simon Edward Lawrence Milner en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de John Richard Moffitt en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Jeremy Kaye en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Peter Glenn James en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Derek Holt en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de John Martin Cleary en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Stephen Paul Humphries en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Robert Blandford en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Emanuel Meyr Arbib en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Stuart William Hindle en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Cessation de la nomination de Marcus Peter Bemrose en tant que membre le 15 oct. 2021 | 1 pages | LLTM01 | ||
Modification des informations du membre pour Scotts Film Services Limited le 10 oct. 2021 | 1 pages | LLCH02 | ||
Qui sont les dirigeants de ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEADSTART ADVERTISING PVT LIMITED | Membre désigné de la LLP | Versova Andheri (W) Mumbai 702 Panchvatika Off Yari Road India |
| 199261800001 | ||||||||||||||
| HEADSTART FILMS PVT LTD | Membre désigné de la LLP | Oberoi Springs, Andheri Mumbai C-22404 India |
| 199810120001 | ||||||||||||||
| SCOTTS NOMINEES LIMITED | Membre désigné de la LLP | 1 Union Plaza Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen C/O Paull & Williamsons United Kingdom |
| 142626690001 | ||||||||||||||
| SCOTTS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Membre désigné de la LLP | 1 Union Plaza Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen C/O Paull & Williamsons United Kingdom |
| 147831700001 | ||||||||||||||
| ALEXANDER, David Johnston | Membre de la LLP | Moray Place EH3 6DA Edinburgh 26a United Kingdom | Scotland | 33931930003 | ||||||||||||||
| ARBIB, Emanuel Meyr | Membre de la LLP | 9 Ashworth Road W9 1JW London | United Kingdom | 58363040004 | ||||||||||||||
| BARRETT, Jane Margaret | Membre de la LLP | Ashbrook House Westbrook Street OX11 9QA Blewbury | United Kingdom | 16696840001 | ||||||||||||||
| BEMROSE, Marcus Peter | Membre de la LLP | Ashway CH60 3RD Wirral 6 Merseyside United Kingdom | United Kingdom | 82005430001 | ||||||||||||||
| BLANDFORD, Mark Robert | Membre de la LLP | Old Letton Court Letton HR3 6DT Hereford | United Kingdom | 59504600003 | ||||||||||||||
| BOURKE, John Paget | Membre de la LLP | 48 Parliament Hill NW3 2TL London | England | 62507310001 | ||||||||||||||
| BRACK EN BURY, Frederick Edwin John Gedge | Membre de la LLP | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | 141643090001 | ||||||||||||||
| BUTTERFIELD, Jonathan Russell | Membre de la LLP | Rock House Rockhill, Halberton EX16 7AL Devon | England | 43387510002 | ||||||||||||||
| CASSELL, Richard Alexander | Membre de la LLP | 36 Rylett Road W12 9SS London | United Kingdom | 55918930002 | ||||||||||||||
| CIULLO, Salvatore | Membre de la LLP | 1 Birchwood Dell Bessacarr DN4 6SY Doncaster | United Kingdom | 105184160001 | ||||||||||||||
| CLAPTON, Eric | Membre de la LLP | 8 Cliff Road SS9 1HJ Leigh-On-Sea | United Kingdom | 9879630001 | ||||||||||||||
| CLEARY, John Martin | Membre de la LLP | 15 Burmah Mill Butlers & Colonial Wharf SE1 2PX Shad Thames, London | United Kingdom | 141316120001 | ||||||||||||||
| CLOSE-SMITH, Edward Vivian | Membre de la LLP | Ladymeads Lower Cousley Wood TN5 6HH Wadhurst | United Kingdom | 141466140001 | ||||||||||||||
| COOK, Nicholas Jonathan | Membre de la LLP | Hill House The Street, Hatfield Peverel CM3 2ET Chelmsford | United Kingdom | 141639740001 | ||||||||||||||
| COWAN, Kevin | Membre de la LLP | 8 Knights Gate Bothwell G71 8SS Glasgow | Scotland | 141643140001 | ||||||||||||||
| DYSON, Toni Adele | Membre de la LLP | 45 Tadorne Road KT20 5TF Tadworth | England | 141582750001 | ||||||||||||||
| GREACEN, Robert Dudley | Membre de la LLP | The Manor BA4 4BE Pilton | England | 104781210001 | ||||||||||||||
| HINDLE, Stuart William | Membre de la LLP | Kpmg Llp 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London | England | 141241160001 | ||||||||||||||
| HOLT, Derek | Membre de la LLP | The Old Pond House Broad Street SO24 9AN Alresford | United Kingdom | 141632930001 | ||||||||||||||
| HUMPHRIES, Stephen Paul | Membre de la LLP | Ashbourne Gardens SG13 8BQ Hertford 22 United Kingdom | United Kingdom | 141643160002 | ||||||||||||||
| JAMES, Peter Glenn | Membre de la LLP | 14 Tofts Close Titchmarsh NN14 3DW Kettering | England | 141643170001 | ||||||||||||||
| JENNER, Toby | Membre de la LLP | Phillips Street Neutral Bay North Sydney 24 Nsw 2089 | United Kingdom | 141643180001 | ||||||||||||||
| JILLA, Cyrus David | Membre de la LLP | 8 Chatsworth Road W4 3HY London | United Kingdom | 141466480001 | ||||||||||||||
| KAYE, Jeremy | Membre de la LLP | 11 Tylers Close WD4 9QA Kings Langley | United Kingdom | 141643200001 | ||||||||||||||
| LEAVER, Andrew | Membre de la LLP | 3 Manor Court Barton Under Needwood DE13 8AU Burton-On-Trent | United Kingdom | 141643210001 | ||||||||||||||
| MAGGS, Douglas John | Membre de la LLP | 5 Rosebery Court 15 Charles Street W1J 5DF London | United Kingdom | 141643220001 | ||||||||||||||
| MERRIMAN, Robert | Membre de la LLP | Woodhill Lane Shamley Green GU5 8PZ Surrey Shamley Wood Estate United Kingdom | United Kingdom | 278974600001 | ||||||||||||||
| MILNER, Simon Edward Lawrence | Membre de la LLP | 78 Gloucester Road TW12 2JT Hampton | United Kingdom | 141634020001 | ||||||||||||||
| MOFFITT, John Richard | Membre de la LLP | Redhill Lodge Barrowden LE15 8EN Oakham | England | 141634030001 | ||||||||||||||
| MORIARTY, Steven Patrick | Membre de la LLP | 6 The Ridgeway Fetcham KT2 9AZ Leatherhead | United Kingdom | 141634000001 | ||||||||||||||
| NEILSON, Barry | Membre de la LLP | 4 St. Marks Place EH15 2PY Edinburgh | United Kingdom | 141643230001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headstart Advertising Pvt Limited | 15 oct. 2021 | Panchvatika Off Yari Road, Versova Andheri (W) Mumbai 702 India | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Scotts Film Services Limited | 30 avr. 2020 | Charleston Road North Cove AB12 3ST Aberdeen 159 Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 23 oct. 2016 | 30 avr. 2020 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
ROSSLYN FILM PARTNERSHIP LLP a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over assets | Créé le 13 mai 2005 Livré le 20 mai 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The dedicated account, minimum rental payments, the guarantee and all substitute bank guarantees floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over assets | Créé le 31 mars 2005 Livré le 14 avr. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all its right,title,benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account,assigns all present and future minimum rental payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over assets | Créé le 31 mars 2005 Livré le 14 avr. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all its right,title,benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each and present and future dedicated account,assigns all present and future minimum rental payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over cash deposit | Cré é le 31 oct. 2003 Livré le 14 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the LLP whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 oct. 2003 Livré le 14 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0