THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL)
    Numéro de société OC307243
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP ?

    Adresse du siège social
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société à responsabilité limitée du registre du commerce

    2 pagesLLDS01

    Satisfaction de charge 2 en totalité

    1 pagesLLMR04

    Cessation de la nomination de Richard John Wright en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Mohammed Yusef en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Roger Martin White en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas James Charles Wilson en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Iestyn Milton Williams en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Ross Wright en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Peter Gilhespy Willey en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Paul Mark Weston en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Charles Rushforth Waterer en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Barry John Warne en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Paul Keith Walker en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Vigrass en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de John Rankin Waddell en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Sushil Baldev Wadhwani en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Stanislav Varga en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de David Richmond Turner en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Martin Oliver Tucker en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Dinesh Savji Tosar en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Leslie Tointon en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Charles Toy en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Sivapragasam Thiruchandran en tant que membre le 01 févr. 2023

    1 pagesLLTM01

    Qui sont les dirigeants de THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Membre désigné de la LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Membre désigné de la LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement4244204
    141180020001
    AHMAD, Masood
    Albasit
    Eyhurst Spur
    KT20 6NS Kingswood
    Membre de la LLP
    Albasit
    Eyhurst Spur
    KT20 6NS Kingswood
    United Kingdom141782740001
    AHMAD, Nuzhat
    Albasit Spur
    Eyhurst Spur
    KT20 6NS Kingswood
    Membre de la LLP
    Albasit Spur
    Eyhurst Spur
    KT20 6NS Kingswood
    United Kingdom141877920001
    AHMED, Jahangeer
    Hammond End
    SL2 3LG Farnham Common
    25
    Buckinghamshire
    Membre de la LLP
    Hammond End
    SL2 3LG Farnham Common
    25
    Buckinghamshire
    United Kingdom73162010004
    ALLAMBY, Peter Russell, Dr
    Windlass Avenue
    Ocean Reef
    Wa
    10
    Australia
    Membre de la LLP
    Windlass Avenue
    Ocean Reef
    Wa
    10
    Australia
    United Kingdom124171820002
    ASHMORE, Claude Edward
    Top Floor Flat
    208 Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    Membre de la LLP
    Top Floor Flat
    208 Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    England141877660001
    ASPINALL, Joseph Colin
    Gerna Farm
    Pendle Road
    BB7 4BU Downham
    Membre de la LLP
    Gerna Farm
    Pendle Road
    BB7 4BU Downham
    United Kingdom141882190001
    AVERY GEE, Steven Mark
    38 Eaton Terrace
    SW1W 8TS London
    Membre de la LLP
    38 Eaton Terrace
    SW1W 8TS London
    United Kingdom141877470001
    BAILEY, Ruth
    Vale Road
    High Kelling
    NR25 6RA Holt
    Heathfield
    England
    Membre de la LLP
    Vale Road
    High Kelling
    NR25 6RA Holt
    Heathfield
    England
    England141877670002
    BAILEY-WOODS, Christopher
    Horseferry House
    Horseferry Road
    SW1P 2AW London
    Burberry
    Membre de la LLP
    Horseferry House
    Horseferry Road
    SW1P 2AW London
    Burberry
    United Kingdom141877650003
    BAMFORD, Niall Richard
    Bruton Street
    W1J 6PY London
    11
    England
    Membre de la LLP
    Bruton Street
    W1J 6PY London
    11
    England
    England115337990002
    BARAKAT, Khalid, Dr
    Chinnor Road
    Crowell
    OX39 4RG Chinnor
    West Barn
    Oxfordshire
    Membre de la LLP
    Chinnor Road
    Crowell
    OX39 4RG Chinnor
    West Barn
    Oxfordshire
    England141694180003
    BARBER, Gary James
    Melbourne Road
    WD23 3LL Bushey
    33
    Hertfordshire
    Membre de la LLP
    Melbourne Road
    WD23 3LL Bushey
    33
    Hertfordshire
    United Kingdom141882270001
    BARNATT, Philip John
    Park View House 24 High Street
    Nettleham
    LN2 2PG Lincoln
    Membre de la LLP
    Park View House 24 High Street
    Nettleham
    LN2 2PG Lincoln
    England141877400001
    BARNETT, Michael Forsyth
    Atlas Wynd
    TS15 9AD Yarm
    17
    Cleveland
    Membre de la LLP
    Atlas Wynd
    TS15 9AD Yarm
    17
    Cleveland
    England141595720001
    BEDDIS, Peter John
    Knowles Drive
    B74 2QW Sutton Coldfield
    3
    West Midlands
    England
    Membre de la LLP
    Knowles Drive
    B74 2QW Sutton Coldfield
    3
    West Midlands
    England
    England141877600002
    BELL, David Frank
    Stack Polly
    Woodbank Lane Woodbank
    CH1 6JD Chester
    Membre de la LLP
    Stack Polly
    Woodbank Lane Woodbank
    CH1 6JD Chester
    United Kingdom59242750004
    BELL, Michael George
    Beeches Lane
    Saughall
    CH1 6AU Chester
    Orchard Cottage
    Cheshire
    Membre de la LLP
    Beeches Lane
    Saughall
    CH1 6AU Chester
    Orchard Cottage
    Cheshire
    United Kingdom63398250003
    BEMROSE, Marcus Peter, Sol
    109 Eastham Village Road
    Eastham
    CH62 0AF Wirral
    Bbh Solicitors Eastham Hall
    Merseyside
    Membre de la LLP
    109 Eastham Village Road
    Eastham
    CH62 0AF Wirral
    Bbh Solicitors Eastham Hall
    Merseyside
    United Kingdom72873580004
    BLATCH, Duncan Howard
    54 Knoll Road
    DA5 1BB Bexley
    Membre de la LLP
    54 Knoll Road
    DA5 1BB Bexley
    England141877990001
    BOOTH, John Alan
    Healey Barn
    Quarry View Lower Healey
    OL12 0SY Rochdale
    Membre de la LLP
    Healey Barn
    Quarry View Lower Healey
    OL12 0SY Rochdale
    England141320100001
    BOWSKILL, Richard James
    Bazehill Road
    Rottingdean
    BN2 7DB Brighton
    26
    East Sussex
    Membre de la LLP
    Bazehill Road
    Rottingdean
    BN2 7DB Brighton
    26
    East Sussex
    England141877510001
    BRADLEY, Michael Andrew
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    Membre de la LLP
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    United Kingdom141634070001
    BRIDGER, William Angus
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Membre de la LLP
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United Kingdom141681780001
    BRIGGS, Simon Anthony
    Tanyard Lane
    Danehill
    RH17 7JW Sussex
    Danehill Lodge
    Membre de la LLP
    Tanyard Lane
    Danehill
    RH17 7JW Sussex
    Danehill Lodge
    United Kingdom35543810005
    BRISCOE, Andrew Christopher
    Sheering Mill House
    Sheering Mill Lane
    CM21 9LR Sawbridgeworth
    Membre de la LLP
    Sheering Mill House
    Sheering Mill Lane
    CM21 9LR Sawbridgeworth
    United Kingdom141882380001
    BROADHURST, Paul Antony
    Brooklawn
    Lyminster Road
    BN17 7QQ Lyminster
    Membre de la LLP
    Brooklawn
    Lyminster Road
    BN17 7QQ Lyminster
    England56400770005
    BURDEN, Garry
    Cardwell Barn
    Hostingley Lane, Thornhill
    WF12 0QH Dewsbury
    Membre de la LLP
    Cardwell Barn
    Hostingley Lane, Thornhill
    WF12 0QH Dewsbury
    England63000990003
    BUTLER, Alastair
    Park Street
    07090 Westfield
    214
    New Jersey
    Usa
    Membre de la LLP
    Park Street
    07090 Westfield
    214
    New Jersey
    Usa
    United States141877640003
    CAMPING, Robert Paul
    Belgrave Square
    SW1X 8QR London
    Camping Property 47
    Membre de la LLP
    Belgrave Square
    SW1X 8QR London
    Camping Property 47
    United Kingdom141882390002
    CAPLAN, David Nigel
    Stamford Road
    Easton On The Hill
    PE9 2AZ Stamford
    The Abbey 34
    Membre de la LLP
    Stamford Road
    Easton On The Hill
    PE9 2AZ Stamford
    The Abbey 34
    United Kingdom141454690008
    CHANDLER, Christopher John
    95 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    Membre de la LLP
    95 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HG Birmingham
    United Kingdom50932450008
    CHASE, Satnam Singh
    1 Ansdell Road North
    FY8 4EZ Lytham
    Membre de la LLP
    1 Ansdell Road North
    FY8 4EZ Lytham
    United Kingdom141877840001
    CHAUDHURY, Pratim Kumar
    206 High Street
    SS8 7ST Canvey Island
    Membre de la LLP
    206 High Street
    SS8 7ST Canvey Island
    United Kingdom141774630001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 mai 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.23, LLP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment and charge
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest from time to time in and to the delivery material and the rights and any and all proceeds relating to them. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Columbia Pictures/UK Da Vinci Code Productions Llc
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 févr. 2023Satisfaction d'une charge (LLMR04)
    Charge over assets
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account, the right to demand the same and debts represented thereby including interest. Assigns all right title and interest in and to the minimum revenue entitlement the guarantee and any and all substitute bank guarantees letters of credit deposit or other security. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2022Satisfaction d'une charge (LLMR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0