REPTON FILM PARTNERSHIP LLP

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREPTON FILM PARTNERSHIP LLP
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL)
    Numéro de société OC308650
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Où se situe REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Adresse du siège social
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au05 avr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes de micro-entité établis au 05 avr. 2021

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert Darren Withecombe en tant que membre le 05 mars 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Manish Suchak en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Jonathan Wiles en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de John William Richards en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Patrick James Stead en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Grant Giles en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de David John Farrer en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Michael Andrew Bradley en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Peter Granville Atherton en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Emanuel Meyr Arbib en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Francoise Ellen Atherton en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Cessation de la nomination de Richard Paul Martin Abel en tant que membre le 05 avr. 2021

    1 pagesLLTM01

    Comptes de micro-entité établis au 05 avr. 2020

    3 pagesAA

    Modification des informations du membre pour Navigational Capital, Inc. le 13 sept. 2019

    2 pagesLLCH02

    Déclaration de confirmation établie le 15 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01

    Comptes de micro-entité établis au 05 avr. 2019

    3 pagesAA

    Notification de Graham Bradstreet en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 avr. 2018

    2 pagesLLPSC01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 04 oct. 2019

    2 pagesLLPSC09

    Déclaration de confirmation établie le 15 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesLLCS01

    Cessation de la nomination de Panosh Limited en tant que membre le 26 juil. 2019

    1 pagesLLTM01

    Nomination de Navigational Capital, Inc. en tant qu'associé le 24 avr. 2019

    2 pagesLLAP02

    Nomination de Irelandonscreenlive Limited en tant qu'associé le 17 juin 2019

    2 pagesLLAP02

    Qui sont les dirigeants de REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IRELANDONSCREENLIVE LIMITED
    The Avenue Woodpark
    Ballinteer
    Dublin 16 D16xa97
    11
    Ireland
    Membre désigné de la LLP
    The Avenue Woodpark
    Ballinteer
    Dublin 16 D16xa97
    11
    Ireland
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Numéro d'enregistrement546430
    191961360001
    THROWA LIMITED
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Membre désigné de la LLP
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Numéro d'enregistrement526288
    178741040002
    BCNL HOLDINGS INC.
    c/o G Bradstreet
    Leghorn Ave
    Sherman Oaks
    5343
    Ca 91401
    United States
    Membre de la LLP
    c/o G Bradstreet
    Leghorn Ave
    Sherman Oaks
    5343
    Ca 91401
    United States
    Forme juridiqueLIMITED COMPANY
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleWYOMING, USA
    Numéro d'enregistrement2018-000799693
    260901110002
    CRANNOG FILMS LIMITED
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Membre désigné de la LLP
    Bride Street
    Dublin 8
    Molyneux House
    Ireland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement280953
    178740570001
    SCOTTS NOMINEES LIMITED
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Membre désigné de la LLP
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC224914
    142626690001
    SCOTTS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Membre désigné de la LLP
    1 Union Plaza
    Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    C/O Paull & Williamsons
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC224913
    147831700001
    ABEL, Richard Paul Martin
    High Trees, Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SA Bristol
    Membre de la LLP
    High Trees, Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 7SA Bristol
    United Kingdom141651130001
    ANVARZADEH, Amir Shahriar
    Aston Residence
    209 Jalan Loyang Besar
    Singapore
    01-09
    509489
    Singpore
    Membre de la LLP
    Aston Residence
    209 Jalan Loyang Besar
    Singapore
    01-09
    509489
    Singpore
    Singapore147506880003
    ARBIB, Emanuel Meyr
    9 Ashworth Road
    W9 1JW London
    Membre de la LLP
    9 Ashworth Road
    W9 1JW London
    United Kingdom58363040004
    ARORA, Surinder
    8 Hush Willows
    Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    Membre de la LLP
    8 Hush Willows
    Wentworth Drive
    GU25 4NY Virginia Water
    United Kingdom70271560007
    ATHERTON, Francoise Ellen
    Trewatha
    Oxford Lodge
    MK18 5DA Stowe
    Membre de la LLP
    Trewatha
    Oxford Lodge
    MK18 5DA Stowe
    United Kingdom141310390001
    ATHERTON, Peter Granville, Dr
    Oxford Lodge
    Stowe
    MK18 5DA Buckingham
    Trewetha
    Membre de la LLP
    Oxford Lodge
    Stowe
    MK18 5DA Buckingham
    Trewetha
    England106838980004
    BEANEY, Gerald Douglas
    Grant Thornton
    Melton Street Euston Square
    NW1 2EP London
    Membre de la LLP
    Grant Thornton
    Melton Street Euston Square
    NW1 2EP London
    United Kingdom141507230002
    BRADLEY, Michael Andrew
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    Membre de la LLP
    Moneyer Road
    SP10 4NG Andover
    16
    Hampshire
    United Kingdom141634070001
    BROWNE, David Scott
    Flat 11, Transcend
    110 St. Leonards Road
    SL4 3BJ Windsor
    Membre de la LLP
    Flat 11, Transcend
    110 St. Leonards Road
    SL4 3BJ Windsor
    United Kingdom141651160001
    CRANE, Robert
    79 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Membre de la LLP
    79 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    United Kingdom141651170001
    DRUTTMAN, George Adam Robert
    10 Tadmor Street
    W12 8AH London
    Membre de la LLP
    10 Tadmor Street
    W12 8AH London
    England141227030001
    DYSON, Toni Adele
    45 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Membre de la LLP
    45 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    England141582750001
    FABIAN, Shaun Barry
    12 The Avenue
    BN5 4EN Barnet
    Membre de la LLP
    12 The Avenue
    BN5 4EN Barnet
    United Kingdom78654200003
    FARRER, David John
    The Grange
    50 Main Street Hoby
    LE14 3DT Melton Mowbray
    Membre de la LLP
    The Grange
    50 Main Street Hoby
    LE14 3DT Melton Mowbray
    United Kingdom141651200001
    GILES, Timothy Grant
    Ivy Lodge
    Badby Road
    NN11 3HE Newnham
    Membre de la LLP
    Ivy Lodge
    Badby Road
    NN11 3HE Newnham
    United Kingdom141651230001
    GREGORY, Andrew
    4 Great Molewood
    SG14 2PN Hertford
    Membre de la LLP
    4 Great Molewood
    SG14 2PN Hertford
    United Kingdom141651240001
    GWYN JONES, Timothy
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    Membre de la LLP
    Hamstead Lodge Hampstead House
    Hamstead Marshall
    RG20 0HE Newbury
    United Kingdom48297190002
    HUTCHINSON, Graeme
    16 Shute End
    RG40 1BJ Wokingham
    Hulbert Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    Membre de la LLP
    16 Shute End
    RG40 1BJ Wokingham
    Hulbert Gate
    Berkshire
    United Kingdom
    United Kingdom141651210002
    JARMAN, Trevor Rodney, Dr
    18 Moss Drive
    Haslingfield
    CB3 7JB Cambridge
    Membre de la LLP
    18 Moss Drive
    Haslingfield
    CB3 7JB Cambridge
    England20267110001
    KLEIN, Elizabeth
    Highfield Mews, Compayne Gardens
    NW6 3GB London
    11
    Membre de la LLP
    Highfield Mews, Compayne Gardens
    NW6 3GB London
    11
    141651270002
    LEWIS, Martin Allen
    11 The Ridgeway
    WD7 8PZ Radlett
    Membre de la LLP
    11 The Ridgeway
    WD7 8PZ Radlett
    England141582740001
    MAGGS, Douglas John
    Rosebury Court
    15 Charles Street
    W1J 5EX London
    Flat 7
    Membre de la LLP
    Rosebury Court
    15 Charles Street
    W1J 5EX London
    Flat 7
    England78798720002
    MCANDIE, Stewart Cameron
    81 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RW London
    Membre de la LLP
    81 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RW London
    United Kingdom141442150001
    MCKENCHNIE, Timothy James
    Broadway Road
    GU20 6DA Windlesham
    Springhill
    Surrey
    United Kingdom
    Membre de la LLP
    Broadway Road
    GU20 6DA Windlesham
    Springhill
    Surrey
    United Kingdom
    United Kingdom141651280002
    PARKINSON, Noel David
    Station Road
    South Cave
    EU15 2AG Brough
    Drewton Farm
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Membre de la LLP
    Station Road
    South Cave
    EU15 2AG Brough
    Drewton Farm
    East Yorkshire
    United Kingdom
    England141649670002
    PEPPER, Andrew John
    Little Frenchs Farm House
    Snow Hill
    RH10 3EG Crawley
    Membre de la LLP
    Little Frenchs Farm House
    Snow Hill
    RH10 3EG Crawley
    England153926200001
    PRICE, Mark
    Copt Hill
    Danbury
    CM3 4NW Chelmsford
    Dane Court
    United Kingdom
    Membre de la LLP
    Copt Hill
    Danbury
    CM3 4NW Chelmsford
    Dane Court
    United Kingdom
    United Kingdom117299680002
    RICHARDS, John William
    Le Millefiori
    1 Rue De Genets
    Mc98000
    11b
    Monaco
    Monaco
    Membre de la LLP
    Le Millefiori
    1 Rue De Genets
    Mc98000
    11b
    Monaco
    Monaco
    Monaco141640370004
    ROTTGEN, Raphael
    29a Neal Street
    WC2H 9PR London
    Membre de la LLP
    29a Neal Street
    WC2H 9PR London
    United Kingdom141633620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Graham Bradstreet
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    20 avr. 2018
    C/O Turcan Connell
    12 Stanhope Gate
    W1K 1AW London
    Non
    Nationalité: New Zealander
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la LLP.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour REPTON FILM PARTNERSHIP LLP ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    15 juil. 201620 avr. 2018La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    REPTON FILM PARTNERSHIP LLP a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over assets
    Créé le 16 janv. 2013
    Livré le 30 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "mine ha ha" see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 30 janv. 2013Enregistrement d'une charge (LLMG01)
    Charge over assets
    Créé le 16 janv. 2013
    Livré le 30 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "fire" see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 30 janv. 2013Enregistrement d'une charge (LLMG01)
    Charge over assets
    Créé le 16 janv. 2013
    Livré le 30 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "volcano" see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 30 janv. 2013Enregistrement d'une charge (LLMG01)
    Charge over assets
    Créé le 16 janv. 2013
    Livré le 30 janv. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof the rights to demand the same and the debts represented thereby and by way of first ranking absolute assignment all present and future minimum rental payments under the lease agreement relating to the film entitled "tempesta" see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 30 janv. 2013Enregistrement d'une charge (LLMG01)
    A charge over assets relating to the film "nature unleashed - volcano"
    Créé le 08 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account together with any proceeds tehreof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    A charge over assets
    Créé le 04 août 2005
    Livré le 12 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each dedicated account together with any proceeds tehreof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over assets
    Créé le 04 août 2005
    Livré le 12 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all its right title benefit and interest all secured liabilities all moneys any proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 12 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over assets
    Créé le 09 juin 2005
    Livré le 17 juin 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title benefit and interest in and to all money from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with any proceeds thereof assigns all present and future minimal rental payments the guarantee any and all substitute bank guarantees floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 17 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Charge over assets
    Créé le 12 mai 2005
    Livré le 20 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The dedicated account, minimum rental payments, the guarantee and all substitute bank guarantees floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 20 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0