STOS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTOS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC001827
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STOS PLC ?

    • (6523) /

    Où se situe STOS PLC ?

    Adresse du siège social
    110 Queen Street
    G1 3BX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STOS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SECURITIES TRUST OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY13 févr. 188913 févr. 1889

    Quels sont les derniers comptes de STOS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2002

    Quels sont les derniers dépôts pour STOS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    10 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de , 95 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JZ à 110 Queen Street Glasgow G1 3BX le 20 oct. 2015

    2 pagesAD01

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    1 pages169

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Liq appointed 27/06/05
    RES13

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Statuts

    95 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed securities trust of scotland pub lic LIMITED company\certificate issued on 23/06/05
    4 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes intermédiaires établis au 31 mars 2005

    11 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de STOS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ES Edinburgh
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ES Edinburgh
    573240002
    BERRY, Charles Andrew
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish109780690001
    BIRRELL, David
    36 East Barnton Avenue
    EH4 6AQ Edinburgh
    Administrateur
    36 East Barnton Avenue
    EH4 6AQ Edinburgh
    British115290001
    COLE-HAMILTON, Arthur Richard
    Fairways 26 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    Fairways 26 Lady Margaret Drive
    KA10 7AL Troon
    Ayrshire
    British128730001
    DONALDSON, Michael Neil
    St Leonards House 26 Hepburn Gardens
    KY16 9DE St Andrews
    Fife
    Administrateur
    St Leonards House 26 Hepburn Gardens
    KY16 9DE St Andrews
    Fife
    ScotlandBritish46880540002
    FREW, Anita Margaret
    51 Elystan Place
    Chelsea
    SW3 3JY London
    Administrateur
    51 Elystan Place
    Chelsea
    SW3 3JY London
    United KingdomBritish24689070002
    IRVINE, Andrew Robertson
    21 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    21 Midmar Gardens
    EH10 6DY Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish1100340001
    KENNEDY, William Michael Clifford
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    Administrateur
    Oak Lodge
    Inveresk
    EH21 7TE Musselburgh
    British295080001
    MAPCHERSON, Ian
    64 Buchanan Gardens
    KY16 9LX St Andrews
    Fife
    Administrateur
    64 Buchanan Gardens
    KY16 9LX St Andrews
    Fife
    British33670620001
    MILLAR, Robert Peter Wharton
    Mains Of Orton
    Orton
    IV32 7QE Fochabers
    Morayshire
    Administrateur
    Mains Of Orton
    Orton
    IV32 7QE Fochabers
    Morayshire
    ScotlandBritish1176860001
    MILLER, Ronald Andrew Baird, Sir
    7 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 Doune Terrace
    EH3 6DY Edinburgh
    Midlothian
    British10350001
    MORRISON, William Morrison
    14 Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    Midlothian
    British425520001
    MURRAY, Edward Davidson
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    27 Barnshot Road
    EH13 0DJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish504780001
    RANKIN, Alick Michael, Sir
    Tullymoy House
    PH1 3SL Glenalmond
    Perthshire
    Administrateur
    Tullymoy House
    PH1 3SL Glenalmond
    Perthshire
    British35521770003
    WALKER, Michael John
    Templecroft
    Templar Place
    EH31 2AH Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Templecroft
    Templar Place
    EH31 2AH Gullane
    East Lothian
    United KingdomBritish1198700002
    WEIR, John Mcnair
    Endrigg 25 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    Angus
    Administrateur
    Endrigg 25 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NU Dundee
    Angus
    British620380001
    WHITAKER, David Alexander
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Administrateur
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    ScotlandBritish26878690001
    WILSON, Andrew George
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    Administrateur
    Little Carbeth
    G63 9QJ Killearn
    Glasgow
    British782420001
    YOUNG, Robin
    36 Colinton Road
    EH10 5DG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Colinton Road
    EH10 5DG Edinburgh
    Midlothian
    British49790001

    STOS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 04 mai 2001
    Livré le 18 mai 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC Acting as Trustee
    Transactions
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mai 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 04 mai 2001
    Livré le 18 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under a loan agreement dated 2 december 1999
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Trustee
    Transactions
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 mai 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 12 févr. 1991
    Livré le 19 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Trustco Finance PLC
    Transactions
    • 19 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 avr. 1986
    Livré le 07 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000,000 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1983
    Livré le 16 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000.00 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Agreement and floating charge
    Créé le 01 juin 1983
    Livré le 16 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £650,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Insurance Corporation LTD
    Transactions
    • 16 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 01 juin 1983
    Livré le 16 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    STOS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juin 2005Commencement of winding up
    22 août 2018Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0