THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC001846
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY PLC02 avr. 188902 avr. 1889

    Quels sont les derniers comptes de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    10 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA à Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 20 juil. 2018

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 19 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 pagesAD02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 juin 2018

    LRESSP

    Nomination de Miss Zahra Peermohamed en tant que secrétaire le 01 mars 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que secrétaire le 28 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Stephen Roy Slocombe en tant que directeur le 28 févr. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Paul Stewart Girling en tant qu'administrateur le 11 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Damien Ivo Karlov en tant que directeur le 28 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Manager Derek Carter en tant qu'administrateur le 24 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anupam Manchanda en tant que directeur le 02 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Satisfaction de la charge 405 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 404 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 399 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 369 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 395 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 320 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 347 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    Secrétaire
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    British117898690001
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Secrétaire
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, David Allan
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    Secrétaire
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    British37710002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    PARSONS-WEISS, Beatrix
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secrétaire
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    German93618170002
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secrétaire
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243694040001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Secrétaire
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    British55097590003
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Secrétaire
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    ABRAMSON, Christoffer
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Administrateur
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Swedish98463110004
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Administrateur
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BIRCH, Paul Adrian
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Administrateur
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    ScotlandBritish772720001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Administrateur
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURTON, Caroline Mary
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    Administrateur
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    EnglandBritish596070001
    CAIRNS, James Scott
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    British33041530001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Administrateur
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Administrateur
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Administrateur
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JACK, Robert Barr, Professor
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    Administrateur
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    ScotlandBritish940950004
    KANE, William James
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    Administrateur
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    British73972820001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Administrateur
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Administrateur
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    Administrateur
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910001
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Administrateur
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MACPHERSON, John Hannah Forbes
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Administrateur
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    British295710001
    MALCOLM, David
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    Administrateur
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    British295690001
    MANCHANDA, Anupam
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Administrateur
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish139855250001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    14 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Cash deposit pledge
    Créé le 26 mai 2004
    Livré le 03 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Cash deposit pledge
    Créé le 23 avr. 2004
    Livré le 06 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Cash deposit pledge
    Créé le 03 févr. 2004
    Livré le 16 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The charged account and deposit. Account no. 06019951 and the sum of £1,276,957.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Cash deposit pledge
    Créé le 20 janv. 2004
    Livré le 30 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Company pledges and assigns the charged account and deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 déc. 2003
    Livré le 13 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 1.358 ha situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of rents
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brèves mentions
    The rental income in relation to 27 milton link, newcraighall, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 04 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole of the obligations as contained in the contract
    Brèves mentions
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Meadowfield Developments Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 04 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole obligations as contained in the contract
    Brèves mentions
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Meadowfield Developments Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 août 2003
    Livré le 04 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole obligations as contained in the contract
    Brèves mentions
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Meadowfield Developments Limited
    Transactions
    • 04 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of a trust deed
    Brèves mentions
    201/205 x 207 dalry road and 24 orwell terrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Brèves mentions
    The subjects on the east side of mavor avenue and the north side of howard avenue, east kilbride--title number LAN36104.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as defined in the trust deed
    Brèves mentions
    32/46 houston street, glasgow--title number GLA33572.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Brèves mentions
    19-25 houston street, glasgow--title number GLA102404 and 33 houston street, glasgow--title number GLA102402.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 20 juin 2003
    Livré le 08 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as in the trust deed
    Brèves mentions
    The subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 18 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piccadilly trading estate, manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The road on the north or northwest leading from cadzoe street to hamilton station, hamilton.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    223/229 ingram street and 91 miller street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of ground situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road link/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    201/205 dalry road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Princes mall shopping centre, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 janv. 2003
    Livré le 20 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    42/50 watt street, glasgow--title number GLA93893.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 sept. 2019Due to be dissolved on
    19 juin 2018Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0