CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC004676 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 13 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Bruce Robinson en tant que directeur le 14 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Haysmacintyre Company Secretaries Limited le 18 déc. 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Thomas Mabry le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Michael Teasdale le 18 déc. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Holiday Inn 107 Queensferry Road Edinburgh EH4 3HL à Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 03 nov. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge SC0046760005 | 5 pages | MR05 | ||||||||||
La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge SC0046760004 | 5 pages | MR05 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 10 juil. 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 03 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Justin Bruce Robinson le 20 févr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Ivaylo Kolev en tant que directeur le 17 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Loynes en tant que directeur le 17 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Loynes en tant que secrétaire le 17 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Skardon Francis Baker en tant que directeur le 17 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| MABRY, Patrick Thomas | Administrateur | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | Luxembourg | German | 204005420001 | |||||||||
| TEASDALE, Simon Michael | Administrateur | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 204008350001 | |||||||||
| BOLTON, Susan | Secrétaire | 10 Haygreen Close KT2 7TS Kingston Upon Thames Surrey | British | 59426570001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secrétaire | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| COMBEER, Jean Brenda | Secrétaire | Robin Hill 3 St Johns Avenue KT22 7HT Leatherhead Surrey | British | 50345500001 | ||||||||||
| CRANE, Julia Alison | Secrétaire | 27 Hatton Court Lubbock Road BR7 5JQ Chislehurst Kent | British | 46318020001 | ||||||||||
| ENGMANN, Catherine | Secrétaire | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||||||
| LOYNES, Paul | Secrétaire | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | 203612770001 | |||||||||||
| TOON, Samantha Anne | Secrétaire | 10 St.Anthonys Court Nightingale Lane SW12 8NS London | British | 32930670001 | ||||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Secrétaire | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alison | Secrétaire | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Ten Bishops Square Eighth Floor E1 6EG London 10 United Kingdom |
| 125623230001 | ||||||||||
| BAKER, Skardon Francis | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 | United Kingdom | American | 196342720001 | |||||||||
| CASTON, Robert Warwick | Administrateur | Square De Heeus 20 FOREIGN 1400 Brussels Belgium | British | 1311840002 | ||||||||||
| EKAS, Petra Cecilia Maria | Administrateur | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 169731050002 | |||||||||
| FISH, Andrew John | Administrateur | Cherry Tree Cottage Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | England | British | 77133450001 | |||||||||
| GRAHAM, Ian Christopher | Administrateur | Avenue Venus 2 1410 Waterloo Belgium | British | 31551670001 | ||||||||||
| JACKMAN, Robert Loehr | Administrateur | 4 Durning Place SL5 7EZ Ascot Berkshire | American | 35835670003 | ||||||||||
| KOLEV, Ivaylo | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 | Uk | Bulgarian | 193389430001 | |||||||||
| LOYNES, Paul | Administrateur | St. George Street W1S 1FS London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 241370450001 | |||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Administrateur | Regents Park Road NW1 8XL London 120 | United States | 112396050001 | ||||||||||
| MCEWAN, Allan Scott | Administrateur | 29 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 75569660002 | |||||||||
| NEWMAN, Mark | Administrateur | Flat 7 44 Sloane Street SW1X 9LU London | United Kingdom | Canadian | 62529820001 | |||||||||
| PRINCE, Ryan David | Administrateur | 7a Howick Place SW1P 1DZ London 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 85682450077 | |||||||||
| REES, Sally Irene | Administrateur | 3 Sandown Gate KT10 9LB Esher Surrey | England | British | 49954790002 | |||||||||
| RITSON, Leslie David | Administrateur | Old Middle Cator House Cator Widecombe In The Moor TQ13 7UA Newton Abbot Devonshire | British | 26098610002 | ||||||||||
| ROBINSON, Justin Bruce | Administrateur | 20 Castle Terrace EH1 2EG Edinburgh Saltire Court | United Kingdom | British | 225299130001 | |||||||||
| SPRINGETT, Catherine Mary | Administrateur | The Coach House 32 Kerrison Road Ealing W5 5NW London | United Kingdom | British | 147336720001 | |||||||||
| STOCKS, Nigel Peter | Administrateur | Birdwoods School Lane Shackleford GU8 6AZ Godalming Surrey | United Kingdom | British | 147336730001 | |||||||||
| VAN OOSTEROM, Sophie | Administrateur | Orlando Road SW4 0LD London 19 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 139801070001 | |||||||||
| WHITNEY, Paul Sumpter | Administrateur | The Barnstead Evenley NN13 5SG Brackley Northants | British | 418890001 | ||||||||||
| WINTER, Richard Thomas | Administrateur | 33 St Johns Avenue Putney SW15 6AL London | United Kingdom | British | 6308500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribbon Hotels Group (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | Red Lion Square WC1R 4AG London 26 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 02 déc. 2015 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 02 déc. 2015 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 22 mai 2013 Livré le 03 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The security agreement among others the ocmpany and the common security agent creates a fixed charge over present and future land and intellectual property rights owned by the company. Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 22 mai 2013 Livré le 03 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Memorandum of deposit | Créé le 13 févr. 1966 Livré le 22 févr. 1966 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Leasehold premises at kenilworth hotel, great russell street, waverley hotel, southampton row and ivanhoe hotel, bloomsbury street, london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CENTRE HOTELS (CRANSTON) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0