SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
| Numéro de société | SC006655 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK ?
| Adresse du siège social | Mazars Llp 90 St. Vincent Street G2 5UB Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré | 1 pages | AD03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Geoffrey Malcolm Lodge le 27 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2006 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONE, Jeffrey Brian | Secrétaire | Keepers Portesbery Road GU15 3TD Camberley Surrey | British | 35733600002 | ||||||
| BEAL PRESTON, John | Administrateur | 10 Peatmoor Close Church Road GU13 8LE Fleet Hampshire | England | British | 14184950001 | |||||
| LODGE, Geoffrey Malcolm | Administrateur | The Manor House HP22 4HW Oving Aylesbury | United Kingdom | British | 14184980004 | |||||
| MCELLIGOTT, Thomas Gary | Administrateur | Chepstow Portesbery Road GU15 3TF Camberley Surrey | England | British | 51922930003 | |||||
| STONE, Jeffrey Brian | Administrateur | Keepers Portesbery Road GU15 3TD Camberley Surrey | England | British | 35733600002 | |||||
| MACLACHLAN, Alan George | Secrétaire | Park Cottage 1 Church Street Limekilns KY11 3HT Dunfermline Fife Scotland | British | 161950001 | ||||||
| ALLISON, James Norman | Administrateur | Dyke House Rowantreehill Rd PA13 4PE Kilmacolm Renfrewshire | British | 34496350001 | ||||||
| CAMPBELL, Ronald Hugh | Administrateur | 34 Blueberry Road Bowdon WA14 3LU Altrincham Cheshire | British | 711940001 | ||||||
| COOPER, Michael John | Administrateur | 24 Marrowells KT13 9RN Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 67011240001 | |||||
| CURRY, Thomas Peter Ellison | Administrateur | Hurlands Dunsfold Surrey | British | 3959800001 | ||||||
| FAREBROTHER, Michael John | Administrateur | The Old Cottage Pednor HP5 2SX Chesham Buckinghamshire | British | 15332520001 | ||||||
| HERBERT, Jeffrey William | Administrateur | Baytrees Long Road West Dedham CO7 6EL Colchester Essex | England | British | 28246390001 | |||||
| HUME, Jeffrey | Administrateur | 29 Buckles Way SM7 1HB Banstead Surrey | British | 58948740001 | ||||||
| JACKSON, John Bernard Haysom | Administrateur | Summit House Red Lion Square WC1R 4QB London | United Kingdom | British | 98731480001 | |||||
| LINCOLN, Harold Graham Young | Administrateur | 5 Ringbolt Road Hingham 02043 Massachusetts U.S.A | British | 1360220002 | ||||||
| MACLACHLAN, Alan George | Administrateur | Park Cottage 1 Church Street Limekilns KY11 3HT Dunfermline Fife Scotland | British | 161950001 | ||||||
| MACLELLAN, Ian David | Administrateur | Wormleighton Grange CV47 2XZ Southam Warwickshire | United Kingdom | British | 33693580001 | |||||
| MCDOWALL, Andrew Douglas | Administrateur | The Castle House TN14 5PB Otford Kent | British | 1292440001 | ||||||
| MELDAL-JOHNSEN, Konrad Walter | Administrateur | Firfield House Firfields KT13 0UD Weybridge Surrey | England | British | 165200001 | |||||
| MENZIES, Graham Reid | Administrateur | Harcombe House 4 Lambridge Wood Road RG9 3BS Henley On Thames Oxfordshire | British | 68409800001 | ||||||
| MOODIE, Johannes Christiaan | Administrateur | 21 Angulia Park The Parisian *08-01 239974 Singapore | South African | 711930004 | ||||||
| ROBSON, Nigel Edward | Administrateur | Far Rockaway Upper Durford Wood GU31 5AW Petersfield Hampshire | United Kingdom | British | 1306200002 | |||||
| SMITH, Nigel Watkin Roberts | Administrateur | Charleswood House Bull Lane SL9 8RL Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 42608810002 | |||||
| STEWART, Murray John | Administrateur | Suite Ph 103 18 Hollywood Avenue M2N 6P5 North York Ontario Canada | Canadian | 975600003 | ||||||
| WATSON, Ronald Norman Stewart | Administrateur | Dalarne Pier Road G84 8LJ Rhu Dunbartonshire | British | 161980001 |
SPECIALISED ENGINEERING HOLDINGS UK a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 03 déc. 1999 Livré le 10 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0