MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC

MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC006705
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    1 George Street
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MURRAY WESTERN INVESTMENT TRUST PLC18 déc. 190718 déc. 1907

    Quels sont les derniers comptes de MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au06 mai 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation20 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au06 mai 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,893,071.095
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,858,272.095
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    16 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,823,805.595
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 oct. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,822,079.45
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 oct. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Comptes intermédiaires établis au 30 juin 2025

    9 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,819,925.9
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,817,193.15
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 août 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate amount of stamp duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,810,202.35
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,784,895.45
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    23 mai 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,764,980.5
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    16 mai 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction

    Déclaration de confirmation établie le 06 mai 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,713,778.05
    3 pagesSH03

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Nomination de Mr Jeroen Karel Huysinga en tant qu'administrateur le 01 mai 2025

    2 pagesAP01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,676,988
    3 pagesSH03

    Cessation de la nomination de Alexandra Jane Mackesy en tant que directeur le 24 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    139 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,656,056.45
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,623,400.55
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,545,545.4
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,583,139.35
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,522,024.85
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,431,089.7
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,370,805.4
    3 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 2,291,095.25
    3 pagesSH03

    Qui sont les dirigeants de MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABRDN HOLDINGS LIMITED
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement82015
    127718210003
    BINYON, Claire Margaret
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish245933730001
    COLQUHOUN, Wendy Margaret
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    ScotlandBritish141531540001
    ECKERSLEY, Gregory Douglas
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish173779200002
    HOLMES, Virginia Anne
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish67842780001
    HUYSINGA, Jeroen Karel
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish271193200001
    MELHUISH, Nicholas James Anthony
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    United KingdomBritish113706400002
    MURRAY JOHNSTONE LIMITED
    One Albyn Place
    AB10 1YG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    One Albyn Place
    AB10 1YG Aberdeen
    Aberdeenshire
    27580002
    BENSON, David Holford
    11 Brunswick Gardens
    W8 4AS London
    Administrateur
    11 Brunswick Gardens
    W8 4AS London
    United KingdomBritish61129110001
    BEST, James Douglas
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    Administrateur
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    United KingdomCanadian72480510003
    BROWN, Ella Irene
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    Administrateur
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    United KingdomBritish114636610001
    BRUCE, Janet Patricia, Lady Balfour Of Burleigh
    Farringdon Place
    20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    Administrateur
    Farringdon Place
    20 Farringdon Road
    EC1M 3AP London
    United KingdomBritish117611390002
    BURNETT-STUART, Joseph, Mr.
    Micheldever House
    Micheldever
    SO21 3DF Winchester
    Hants
    Administrateur
    Micheldever House
    Micheldever
    SO21 3DF Winchester
    Hants
    United KingdomBritish1410250003
    CAMPBELL, Marcia Dominic
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    ScotlandBritish62708600001
    CARTER, Kevin James, Dr
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    United KingdomBritish10570530007
    COATS, William David, Sir
    The Cottage
    KA1 5QG Symington
    Ayrshire
    Administrateur
    The Cottage
    KA1 5QG Symington
    Ayrshire
    British27600001
    CUTHBERT, William Moncrieff
    Old Ballinkinrain
    Balfron
    G63 0LP Glasgow
    Administrateur
    Old Ballinkinrain
    Balfron
    G63 0LP Glasgow
    British27610001
    DENHOLM, John Ferguson, Sir
    Newton Of Belltrees
    PA12 4JL Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Administrateur
    Newton Of Belltrees
    PA12 4JL Lochwinnoch
    Renfrewshire
    British177430001
    DUNSCOMBE, Peter William
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    United KingdomBritish7503690001
    FERGUSSON, Adam Dugdale
    15 Warwick Gardens
    W14 8PH London
    Administrateur
    15 Warwick Gardens
    W14 8PH London
    British42983970001
    FRASER, Simon
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish269518050001
    HARDIE, David
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    ScotlandBritish47948570001
    HARDMAN, Blaise Noel Anthony
    Farley House
    Farley Chamberlayne
    SO51 0QR Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Farley House
    Farley Chamberlayne
    SO51 0QR Romsey
    Hampshire
    British1323260001
    JOHNSTONE, Raymond, Sir
    Wards
    Gartocharn
    G83 8SB Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Wards
    Gartocharn
    G83 8SB Alexandria
    Dunbartonshire
    British46265160001
    MACKESY, Alexandra Jane
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1 George Street
    Scotland
    EnglandBritish135345220001
    MACPHERSON, Ewen Alan
    Attadale
    IV54 8YX Strathcarron
    Wester Ross
    Administrateur
    Attadale
    IV54 8YX Strathcarron
    Wester Ross
    United KingdomBritish36974650001
    SHEA, Michael Sinclair, Dr
    1a Ramsay Garden
    EH1 2NA Edinburgh
    Administrateur
    1a Ramsay Garden
    EH1 2NA Edinburgh
    British38326850001
    SHEDDEN, Alfred Charles
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    Administrateur
    7th Floor
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    ScotlandBritish1213170002
    STEPHEN, Alexander Moncrieff Mitchell
    Ballindalloch
    Balfron
    G63 0LP Glasgow
    Administrateur
    Ballindalloch
    Balfron
    G63 0LP Glasgow
    British27640001
    SUTHERLAND, Donald Gilmour
    Woodside House
    Gladsmuir
    EH33 2AL Tranent
    East Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Woodside House
    Gladsmuir
    EH33 2AL Tranent
    East Lothian
    Scotland
    British43937610001
    TROTT, John Francis Henry
    Odstock
    Castle Square
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Administrateur
    Odstock
    Castle Square
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British38785870001
    THE RT HON VISCOUNT YOUNGER OF LECKIE
    Leckie House
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    Scotland
    Administrateur
    Leckie House
    Gargunnock
    FK8 3BN Stirling
    Scotland
    35097950003

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0