DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED

DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC007962
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Randolph Place
    Randolph Industrial Estate
    KY1 2YX Kirkcaldy
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Mark South en tant que directeur le 08 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Application to be struck off and dissolved 17/02/2017
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark South le 23 déc. 2016

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Mark South en tant qu'administrateur le 23 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven Richard Finch en tant que directeur le 22 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel James Hiorns en tant que secrétaire le 22 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Andrew Lawler en tant que secrétaire le 22 déc. 2016

    2 pagesAP03

    État du capital au 26 oct. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 avr. 2016

    État du capital au 15 avr. 2016

    • Capital: GBP 3,775
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 avr. 2015

    État du capital au 21 avr. 2015

    • Capital: GBP 3,775
    SH01

    Cessation de la nomination de Denis Michael Embleton en tant que directeur le 27 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Quinn le 17 nov. 2014

    2 pagesCH01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAWLER, David Andrew
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    United Kingdom
    221205680001
    QUINN, Kevin
    c/o Berendsen Uk Limited
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    England
    Administrateur
    c/o Berendsen Uk Limited
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    England
    EnglandBritish89902020003
    HIORNS, Nigel James
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    Secrétaire
    62 Church Road
    CR0 1SB Croydon
    Surrey
    British11524610002
    LONIE, Jean Adie
    276 Overton Mains
    KY1 3JS Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    276 Overton Mains
    KY1 3JS Kirkcaldy
    Fife
    British79464850001
    SANDIE, James Scott
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    Secrétaire
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    British34380240001
    CALDER, Graeme Stuart Mclennan
    4 Middlefield Brae
    KY15 4BX Cupar
    Fife
    Administrateur
    4 Middlefield Brae
    KY15 4BX Cupar
    Fife
    British932440001
    EMBLETON, Denis Michael
    9 Leydene Park
    Hyden Farm Lane East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    9 Leydene Park
    Hyden Farm Lane East Meon
    GU32 1HF Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish12722390003
    FINCH, Steven Richard
    2 Regency Court
    Langley Road
    WD17 4RG Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Regency Court
    Langley Road
    WD17 4RG Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish38003430003
    HILL, Alan C
    Braemount
    KY1 1UW Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    Braemount
    KY1 1UW Kirkcaldy
    Fife
    British533980003
    HILL, Ian
    47 The Wynd
    Dalgety Bay
    KY11 9SJ Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    47 The Wynd
    Dalgety Bay
    KY11 9SJ Dunfermline
    Fife
    British164600001
    SANDIE, James Scott
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    Administrateur
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    British34380240001
    SOUTH, Mark
    c/o Berendsen Plc
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    England
    Administrateur
    c/o Berendsen Plc
    Grosvenor Place
    SW1X 7DL London
    4
    England
    United KingdomBritish221291190001

    DUNFERMLINE AND WEST FIFE LAUNDRY, LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 09 août 1993
    Livré le 18 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    30 church street, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • The Fife Regional Council
    Transactions
    • 18 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 août 1993
    Livré le 05 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of ground part of the lands of ravenscraig and dysart lying on the south side of church street, kirkcaldy.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 août 1993
    Livré le 11 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 11 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 03 août 1993
    Livré le 09 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Under exception of the premises known as 11 durie street, leven, fife; 81 st. Clair street, kirkcaldy, fife; 129 south street, st. Andrews, fife; 39 whytecauseway, kirkcaldy, fife; 114 queensferry road (palace buildings), rosyth, fife; and stance number 1, bassaguard industrial development, st. Andrews, fife.. Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Fife Regional Council
    Transactions
    • 09 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 sept. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 sept. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 09 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 15 août 1984
    Livré le 23 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    129 south street st andrews.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 août 1984Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 juin 1982
    Livré le 11 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juin 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 09 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Double shop at 4 and 6 douglas street and a flat above all in dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 09 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop at 39 whytecauseway kirkcaldy, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 05 févr. 1982
    Livré le 09 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole of premises at 134 market street, st. Andrews.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 nov. 1979
    Livré le 11 déc. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole the ground floor shop premises at 114 queensferry road, rosyth, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 déc. 1979Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 mai 1969
    Livré le 22 mai 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 mai 1969Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond and disposition in security
    Créé le 09 mars 1962
    Livré le 10 août 1962
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4,000
    Brèves mentions
    Shop premises 134, market street, st. Andrews.
    Personnes ayant droit
    • Woodburn Laundry Limited
    Transactions
    • 10 août 1962Enregistrement d'une charge
    • 17 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0