UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUNDERSHAFT (BONUS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC008140
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    • Assurance non-vie (65120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pitheavlis
    Perth
    PH2 0NH
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CGU BONUS LIMITED01 oct. 199901 oct. 1999
    GA BONUS LIMITED01 janv. 199201 janv. 1992
    THE NEW ZEALAND INSURANCE PLC20 sept. 198420 sept. 1984

    Quels sont les derniers comptes de UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Certificat de changement de nom

    Company name changed cgu bonus LIMITED\certificate issued on 13/12/12
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 déc. 2012

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name13 déc. 2012

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Nomination de Mr John Patrick Sorrell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Harold Spicker en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Clifford Abrahams en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jessie Burrows en tant que directeur

    1 pagesTM01

    État du capital au 08 nov. 2012

    • Capital: GBP 1,000
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Cessation de la nomination de David Mcmillan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    53 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Jessie Josephine Burrows en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sean Egan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    53 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Sean Egan le 26 août 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Nomination de Mr Clifford James Abrahams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPICKER, Richard Harold
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    Secrétaire
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    British120021510001
    SORRELL, John Patrick
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    England
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    England
    EnglandBritish,Australian174090030001
    SPICKER, Richard Harold
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    England
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    England
    EnglandBritish120021510001
    SHORT, Dianne Elsie
    Brown Cottage Butts Green
    Sandon
    CM2 7RN Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Brown Cottage Butts Green
    Sandon
    CM2 7RN Chelmsford
    Essex
    British607010001
    WHITAKER, Richard Andrew
    Barnkittock House
    Comrie Road
    PH7 4BQ Crieff
    Perthshire
    Secrétaire
    Barnkittock House
    Comrie Road
    PH7 4BQ Crieff
    Perthshire
    British497250002
    WHITE, Philip Martin
    19 Stafford Close
    Chafford Hundred
    RM16 6ND Grays
    Essex
    Secrétaire
    19 Stafford Close
    Chafford Hundred
    RM16 6ND Grays
    Essex
    British41789910003
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Secrétaire
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    ABRAHAMS, Clifford James
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish153206280001
    BIGGS, Michael Nicholas
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    415 Unthank Road
    NR4 7QB Norwich
    Norfolk
    British28234260001
    BURROWS, Jessie Josephine
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish165470180001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Administrateur
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    EGAN, Sean
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandIrish192694110001
    FOUND, Paul Anthony
    23 Verulam Avenue
    CR8 3NR Purley
    Surrey
    Administrateur
    23 Verulam Avenue
    CR8 3NR Purley
    Surrey
    United KingdomBritish59305400001
    HODGES, Mark Steven
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Uk
    Administrateur
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    Uk
    United KingdomBritish58444370003
    HUNT, Jacqueline
    Oakside Cottage
    Norwich Road, Hethersett
    NR9 3DE Norwich
    Administrateur
    Oakside Cottage
    Norwich Road, Hethersett
    NR9 3DE Norwich
    British117817070002
    JACK, William Henderson
    Dalmore Ardchoille Park
    PH2 7TL Perth
    Scotland
    Administrateur
    Dalmore Ardchoille Park
    PH2 7TL Perth
    Scotland
    United KingdomBritish45967520001
    KITSON, John Robert
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    Administrateur
    Surrey Street
    NR1 3NG Norwich
    8
    United KingdomBritish112819810001
    LISTER, Nigel George
    61 Spoutwells Drive
    Scone
    PH2 6PQ Perth
    Administrateur
    61 Spoutwells Drive
    Scone
    PH2 6PQ Perth
    British498400001
    MACDONALD, David Gavin
    24 St. Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    Administrateur
    24 St. Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish124485280001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    MALCOLM, Donald Guy
    54 Queenscliff Road
    Queenscliff
    FOREIGN Sydney
    Australia
    Administrateur
    54 Queenscliff Road
    Queenscliff
    FOREIGN Sydney
    Australia
    New Zealander607020001
    MAYER, Igal Mordeciah
    Cheyne Row
    SW3 5HW London
    31
    United Kingdom
    Administrateur
    Cheyne Row
    SW3 5HW London
    31
    United Kingdom
    United KingdomIsraeli122717100002
    MAYER, Igal Mordeciah
    Kinross
    Manor Lane
    SL9 7NH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Kinross
    Manor Lane
    SL9 7NH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Canadian73418470001
    MCINTYRE, Bridget Fiona
    Thwaite Road
    Thorndon
    IP23 7JJ Eye
    Poplar Farm
    Suffolk
    Administrateur
    Thwaite Road
    Thorndon
    IP23 7JJ Eye
    Poplar Farm
    Suffolk
    EnglandBritish147818340001
    MCMILLAN, David John Ramsay
    Surrey Street
    Norfolk
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    Administrateur
    Surrey Street
    Norfolk
    NR1 3NG Norwich
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish90058230007
    MCMILLAN, David John Ramsay
    10 Saxe Coburg Place
    EH3 5BR Edinburgh
    Administrateur
    10 Saxe Coburg Place
    EH3 5BR Edinburgh
    United KingdomBritish90058230007
    MCMILLAN, David John Ramsay
    10 Saxe Coburg Place
    EH3 5BR Edinburgh
    Administrateur
    10 Saxe Coburg Place
    EH3 5BR Edinburgh
    United KingdomBritish90058230007
    NEWTON, Robert
    Molebank House
    Haydens Close
    GL55 6JN Chipping Campden
    Gloucestershire
    Administrateur
    Molebank House
    Haydens Close
    GL55 6JN Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish114681920001
    RACKLEY, Peter James
    15 Roundwood Grove
    Hutton Mount
    CM13 2NE Brentwood
    Essex
    Administrateur
    15 Roundwood Grove
    Hutton Mount
    CM13 2NE Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish607030001
    RAMSAY, Caroline Francis
    5 Aspland Road
    NR1 1SH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    5 Aspland Road
    NR1 1SH Norwich
    Norfolk
    British95697550001
    ROBERTS, Thomas
    Holly House
    6 Westerhill
    PH1 1DH Perth
    Administrateur
    Holly House
    6 Westerhill
    PH1 1DH Perth
    British49983330001
    SCHRAUWERS, Cornelis Antonius Carolus Maria, Dr
    Nancherrow 14 Littleworth Avenue
    KT10 9PB Esher
    Surrey
    Administrateur
    Nancherrow 14 Littleworth Avenue
    KT10 9PB Esher
    Surrey
    EnglandDutch169548140001
    SCOTT, Robert Avisson
    Glebe House
    Auchterarder Road
    PH2 0RJ Dunning
    Perthshire
    Administrateur
    Glebe House
    Auchterarder Road
    PH2 0RJ Dunning
    Perthshire
    Australian1226660001
    SEATON, John
    204 Hurricane Way
    Woodley
    RG5 4UH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    204 Hurricane Way
    Woodley
    RG5 4UH Reading
    Berkshire
    British91130160001
    SEATON, John
    204 Hurricane Way
    Woodley
    RG5 4UH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    204 Hurricane Way
    Woodley
    RG5 4UH Reading
    Berkshire
    British91130160001

    UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 25 oct. 1993
    Livré le 11 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See companies house microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Pool Reinsurance Company Limited
    Transactions
    • 11 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Reinsurance deposit agreement
    Créé le 14 oct. 1988
    Livré le 02 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement or at any time thereafter during the subsistence of the security constituted by the reinsurance deposit agreement standing to the credit of: (a) each reinsurance deposit or other account with the bank referred to in clause 3(a)(i) of the reinsurance deposit agreement; (b) any account opened by the bank pursuant to clause 11(b) of the reinsurance deposit agreement; or (c) any other account referred to in clause 13 of the reinsurance deposit agreement and, in each case, all entitlements to interest and other rights and benefits accruing to or arising in connection with such monies.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A
    Transactions
    • 02 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 01 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 10 sept. 1980
    Livré le 16 sept. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1/40 waldemar ave mansions, colehill lane, london S.W.6.
    Personnes ayant droit
    • The British Linen Bank Limited
    Transactions
    • 16 sept. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 28 mars 1980
    Livré le 14 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1/15, 16/25, 26/35, 36/50 king's gardens, west end lane, west hampstead, camden.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank Limited
    Transactions
    • 14 avr. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 1980
    Livré le 04 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All that leasehold property known as 20/46 westminster mansions, great smith street, london S.W.1.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank Limited
    Transactions
    • 04 févr. 1980Enregistrement d'une charge

    UNDERSHAFT (BONUS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 déc. 2012Commencement of winding up
    06 mai 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Laura May Waters
    Benson House, 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House, 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Peter James Greaves
    Benson House, 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House, 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0