ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC008975
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    109 Douglas Street
    Glasgow
    G2 4HB
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARBUCKLE, SMITH & COMPANY LIMITED01 déc. 198701 déc. 1987
    ARBUCKLE SMITH (HOLDINGS) LIMITED09 févr. 191409 févr. 1914

    Quels sont les derniers comptes de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Christopher Waters en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2010

    État du capital au 09 sept. 2010

    • Capital: GBP 450,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Exel Nominee No 2 Limited le 10 août 2010

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Exel Secretarial Services Limited le 10 août 2010

    2 pagesCH04

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    5 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    5 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement817717
    32524900007
    TAYLOR, Paul
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    Administrateur
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish105652320001
    EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1183615
    73807850002
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    BUSH, Nicholas James
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    British69612020001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Secrétaire
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    British719840001
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secrétaire
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    British193353200001
    SMITH, Nicholas Leigh
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British45625440002
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    British15165070001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69617780001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    ELLIS, Michael John
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    EnglandBritish133791220001
    GILES, Bruce Sinclair
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    British63973720001
    JOHNSTON, Geoffrey E F
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    British616920001
    KIRKBY, Peter
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    British22731280001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish719840001
    OWER, James
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    British719860001
    PARKHILL, Thomas Cassidy
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    British719870001
    RUSCH, Henry
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    British63973770001
    SMITH, Jamie Robert Mark
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    Administrateur
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish74084830002
    WATERS, Christopher Stephen
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish54969250001
    WILLIS, Nigel A R
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    British616900001
    WOODHAMS, Ernest J
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    Administrateur
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    British616890001

    ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of deposit account
    Créé le 02 juil. 1987
    Livré le 14 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    £300,000 deposit account held by the company with investors in industry PLC.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 10 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 août 1986
    Livré le 21 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lease granted by the city of glasgow district council in favour of the company over 5 acres and 3 1/10TH parts of an acre.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 oct. 1984
    Livré le 30 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due not exceeding £300,000
    Brèves mentions
    89/99 mitchell st. Glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 oct. 1984
    Livré le 30 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warehouse at ferry rd glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 18 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 1984
    Livré le 26 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Steading of ground containing four hundred and eighty eight square yards or thereby lying on the west side of mitchell street, glasgow, in the city parish of glasgow and county of lanark that area of ground extending to one hundred and forty five square yards or thereby lying on the west side of mitchell street aforesaid and in said county.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 10 oct. 1984
    Livré le 22 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots of ground in glasgow first in mitchell street containing 488 sq yards and second plot 145 sq. Yards in mitchel street.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 07 juin 1983
    Livré le 22 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 juin 1983
    Livré le 20 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 05 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 06 mars 1980
    Livré le 11 mars 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £201,686,77
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 4 acres and 37 1/100TH parts of an acre in paisley, renfrew.
    Personnes ayant droit
    • The District Council of Renfrew
    Transactions
    • 11 mars 1980Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation
    Créé le 09 déc. 1975
    Livré le 12 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Endowment policy no.1378328 Dd. 19/9/75 insd. By commercial union assurance co. LTD. On life of geoffrey edward forshaw johnston for £150,000.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Assurance Co. LTD 1 Undershaft, London. EC3P 3DQ
    Transactions
    • 12 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 déc. 1975
    Livré le 05 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Advances made or to be made in terms of agreement at 24TH july & 1ST febry 1973
    Brèves mentions
    Lease of 5.3 acres in ferry rd. Glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Commercial Union Assurance Company LTD
    Transactions
    • 05 déc. 1975Enregistrement d'une charge
    • 27 avr. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 juin 1975
    Livré le 08 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warehouse premises lying to the north of thornliebank road, lanark.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 15 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0