GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED

GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEORGE WATERSTON & SONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC009131
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED ?

    • (2222) /
    • (5164) /
    • (5248) /

    Où se situe GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    3 pages4.17(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Avis du rapport du séquestre

    9 pages3.5(Scot)

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    5 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    11 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2002

    26 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    9 pages466(Scot)

    legacy

    7 pages410(Scot)

    legacy

    5 pages410(Scot)

    legacy

    5 pages410(Scot)

    legacy

    5 pages410(Scot)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Secrétaire
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    38051430002
    DOUGLAS, Graeme Scott
    10 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Corstorphine Hill Gardens
    EH12 6LA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish596420001
    WALLACE, George Paton
    86/2 Mcdonald Road
    EH7 4NU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    86/2 Mcdonald Road
    EH7 4NU Edinburgh
    Midlothian
    British68594320001
    WATERSTON, Geoffrey Sansome
    Macgill Cottage
    Ford
    EH37 5RE Pathhead
    Midlothian
    Administrateur
    Macgill Cottage
    Ford
    EH37 5RE Pathhead
    Midlothian
    United KingdomBritish63914150001
    CORMACK, Anthony James
    32 Golf Course Road
    EH19 2HZ Bonnyrigg
    Midlothian
    Secrétaire
    32 Golf Course Road
    EH19 2HZ Bonnyrigg
    Midlothian
    British566160001
    GIBSON, Brian Hugh
    62 Curriehill Castle Drive
    EH14 5TD Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    62 Curriehill Castle Drive
    EH14 5TD Balerno
    Midlothian
    British222700001
    BARR, James
    74 Belgrave Road
    EH12 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    74 Belgrave Road
    EH12 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    British1273150001
    BARR, James
    74 Belgrave Road
    EH12 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    74 Belgrave Road
    EH12 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    British1273150001
    CLEGG, Harry Bernulf
    3 Zetland Place
    EH5 3HU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Zetland Place
    EH5 3HU Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish596400001
    CORMACK, Anthony James
    32 Golf Course Road
    EH19 2HZ Bonnyrigg
    Midlothian
    Administrateur
    32 Golf Course Road
    EH19 2HZ Bonnyrigg
    Midlothian
    British566160001
    DIMELOW, Henry Graeme
    64 Springfield
    EH6 5SE Edinburgh
    Administrateur
    64 Springfield
    EH6 5SE Edinburgh
    British56024380001
    GIBSON, Brian Hugh
    62 Curriehill Castle Drive
    EH14 5TD Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    62 Curriehill Castle Drive
    EH14 5TD Balerno
    Midlothian
    British222700001
    GRIGGS, Russel George, Professor
    Norhurst
    St Marys Street
    DG4 6BW Sanquhar
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Norhurst
    St Marys Street
    DG4 6BW Sanquhar
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish971540001
    TURNBULL, Brian Wason
    10 Inveralmond Grove
    EH4 6RA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Inveralmond Grove
    EH4 6RA Edinburgh
    Midlothian
    British1133950001

    GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 06 févr. 2003
    Livré le 14 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    The obligations as contained in the agreement
    Brèves mentions
    The stock-in-trade of the company from time to time including (without limiting the foregoing generality) stock, raw materials, work in progress, finished goods, stationery and computer consumeables, goods purchased for resale, component parts, catalogues, advertising and promotional material and packaging (and in every such case whether subject to retention of title or not) (the waterston stock).
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alasdair Johnstone Smith and Others
    Transactions
    • 14 févr. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Agreement incorporating assignation in security
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums in respect of lease agreement.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Scotland Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Agreement incorporating assignation in security
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums in respect of factoring agreement.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Asset Finance Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Asset Finance Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Assignation in security
    Créé le 12 déc. 2002
    Livré le 30 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The obligation of adam & company PLC to make payment to the company of sums held at credit of each and every joint account of george waterson & sons limited and ama (fusion) limited.
    Personnes ayant droit
    • Pearl Holdings (Europe) Limited
    Transactions
    • 30 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 déc. 2002
    Livré le 20 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pearl Holdings (Europe) Limited
    Transactions
    • 20 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 avr. 2002
    Livré le 20 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All obligations as contained in the factoring agreement
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bibby Factors Scotland Limited
    Transactions
    • 20 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 déc. 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 06 déc. 2007Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
      • Numéro de dossier 1
    Standard security
    Créé le 21 mars 2002
    Livré le 29 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    11 warriston road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 29 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 mars 2002
    Livré le 21 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 21 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    24 and 26 beaverhall road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14-16 beaverhall road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    67 & 67A logie green road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    67 & 67A logie green road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warriston works, 11 warriston road, edinburgh (see paper apart to document).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Warriston works, 11 warriston road, edinburgh (see paper apart to document).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    24 and 26 beaverhall road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 avr. 1993
    Livré le 21 avr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    14-16 beaverhall road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 avr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 05 août 1975
    Livré le 06 août 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 août 1975Enregistrement d'une charge
    • 16 juin 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 05 août 1975
    Livré le 06 août 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 août 1975Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 04 juil. 1975
    Livré le 25 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Wharehouse & land at 66 craighall rd, edin.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 juil. 1975
    Livré le 25 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Wharehouse & land at 66 craighall rd, edin.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    GEORGE WATERSTON & SONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2002Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Fraser James Gray
    Afton House
    26 West Nile Street
    G1 2PF Glasgow
    practitioner
    Afton House
    26 West Nile Street
    G1 2PF Glasgow
    David John Whitehouse
    Kroll
    Afton House
    G1 2PF 26 West Nile Street
    Glasgow
    practitioner
    Kroll
    Afton House
    G1 2PF 26 West Nile Street
    Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    01 mai 2010Dissolved on
    31 oct. 2006Petition date
    18 janv. 2010Conclusion of winding up
    31 oct. 2006Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0