CAIRD GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAIRD GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC010344
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAIRD GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAIRD GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAIRD GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    A. CAIRD & SONS, PUBLIC LIMITED COMPANY21 avr. 191921 avr. 1919

    Quels sont les derniers comptes de CAIRD GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CAIRD GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    10 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF à 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 13 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 déc. 2016

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 48 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Gibson Orr le 15 juil. 2016

    2 pagesCH01

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    legacy

    2 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Consolidation des actions au 24 juin 2016

    5 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Ordinary shares consolidated 24/06/2016
    RES13

    Nomination de Mr David Gibson Orr en tant qu'administrateur le 01 juin 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Philip Bernard Griffin-Smith en tant qu'administrateur le 01 juin 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Toby Richard Woolrych en tant que directeur le 01 juin 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter George Dilnot en tant que directeur le 01 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2016

    État du capital au 06 mai 2016

    • Capital: GBP 4,257,212
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 mai 2015

    État du capital au 08 mai 2015

    • Capital: GBP 4,257,212
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2014

    État du capital au 07 mai 2014

    • Capital: GBP 4,257,212
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CAIRD GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    British130189950001
    GRIFFIN-SMITH, Philip Bernard
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish130189950001
    ORR, David Gibson
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    c/o Shanks Group Plc
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish203884240002
    EXCELL, Karen Alice
    103 St Olafs Road
    Fulham
    SW6 7DW London
    Secrétaire
    103 St Olafs Road
    Fulham
    SW6 7DW London
    British343060001
    FLYNN, David Robert
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    Elton 11 Brook Road
    Maghull
    L31 3EG Liverpool
    Merseyside
    British34208920001
    GIBSON, Carolyn Ann
    Polo Barn
    Nairdwood Lane
    HP16 0QH Great Missenden
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Polo Barn
    Nairdwood Lane
    HP16 0QH Great Missenden
    Buckinghamshire
    British119043460001
    KAYE, Paul
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Old Market Place
    Market Lane Greet
    GL54 5BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British3245340002
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Secrétaire
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    British18116420006
    ASHTON, John
    Hurst Villa
    Derbyshire Level
    SK13 9PT Glossop
    Derbyshire
    Administrateur
    Hurst Villa
    Derbyshire Level
    SK13 9PT Glossop
    Derbyshire
    British574870001
    AVERILL, Michael Charles Edward
    Little Meadow Upton Road
    Dinton
    HP17 8UQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Little Meadow Upton Road
    Dinton
    HP17 8UQ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish24913560002
    BROWN, Colin Andrew
    The Beeches George Road
    Milford On Sea
    SO41 0RS Lymington
    Hampshire
    Administrateur
    The Beeches George Road
    Milford On Sea
    SO41 0RS Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish38101260002
    CLARK, James Anderson
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    15 Earlspark Road
    Bieldside
    AB15 9BZ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish2203720001
    DILNOT, Peter George
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish166438690001
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Administrateur
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    DRURY, Thomas Waterworth
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Auckland Park
    Mount Farm
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish/Canadian29701240002
    DYE, Kenneth Howard
    9 Greenfell Road
    HP9 2BP Beaconsfield
    Bucks
    Administrateur
    9 Greenfell Road
    HP9 2BP Beaconsfield
    Bucks
    British1368280001
    FARRELL, John Patrick
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    Administrateur
    Broadcroft
    Little Hallingbury
    CM22 7RT Bishops Stortford
    Herts
    United KingdomBritish702300001
    HYNES, Stephen John
    6 The Hoe
    CM12 9XB Billericay
    Essex
    Administrateur
    6 The Hoe
    CM12 9XB Billericay
    Essex
    EnglandBritish70079680002
    JILLINGS, Charles David Owen
    Brockholt
    The Drive
    KT22 8QJ Tyrells Wood
    Surrey
    Administrateur
    Brockholt
    The Drive
    KT22 8QJ Tyrells Wood
    Surrey
    British45948970001
    LINACRE, Peter John
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    11 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HS Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish34646130002
    MASTERSON, Brian Rhys George, Professor
    Toad Hall Carlton Miniott
    YO7 4NJ Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Toad Hall Carlton Miniott
    YO7 4NJ Thirsk
    North Yorkshire
    British3301580001
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    PARKER, Christopher John Mckellen
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Dennes House
    Waltham
    CT4 5SD Canterbury
    Kent
    EnglandBritish18116420006
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British343070001
    ROSS, Lionel Jack
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    15 Valencia Road
    HA7 4JL Stanmore
    Middlesex
    British1338810002
    SURCH, Christopher
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138144350001
    WEIR, David Thomas
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    Administrateur
    21 Longford Way
    Hutton Way
    CM13 2LT Brentwood
    Essex
    UkBritish33621820001
    WELHAM, Fraser Andrew Norton
    Pennard
    Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pennard
    Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    UkBritish105268510002
    WILCOX, David
    4 Trelawne Drive
    GU6 8BS Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    4 Trelawne Drive
    GU6 8BS Cranleigh
    Surrey
    British1233030001
    WOOLRYCH, Toby Richard
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Auckland Park
    Bletchley
    MK1 1BU Milton Keynes
    Dunedin House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish116504630005

    CAIRD GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 09 avr. 1999
    Livré le 23 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects registered as title number LAN1936, LAN50022, LAN51722 and LAN70845.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 11 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 22 oct. 1997
    Livré le 11 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 22 déc. 1992
    Livré le 31 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 31 déc. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 févr. 1991
    Livré le 05 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects north of greengairs rd greengairs riggend lan 1936 hartloup riggend lan 50022 hartloup riggend lan 51722 berryhill cottage riggend lan 70430 berryhill cottage riggend lan 70845.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture creating a fixed and floating charge
    Créé le 27 sept. 1988
    Livré le 13 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 13 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1988
    Livré le 08 févr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Buildings south east side of commercial road, south shields.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 08 oct. 1987
    Livré le 19 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property 6 errol st, peterhead.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property 23 high st, perth 12/14 george st, perth.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property 129 king st, castle douglas.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property, 142 main st, cambuslang, lanarkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property 21 high st & 4 & 6 george st, perth.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property 64 high st, fort william.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property at 19 hopetoun st. Bathgate.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 1987
    Livré le 15 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    56, 58 & 60 guildford st, chertsey.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 25 sept. 1987
    Livré le 15 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8 & 10 stanley st, liverpool.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1986
    Livré le 31 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Commercial road south shields co durham described in a lease.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1986
    Livré le 31 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    36 & 37 the town and garage at the rear of 10 & 12 london road, enfield.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1986
    Livré le 31 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    71 & 71A kings road, chelsea, london SW3.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 11 mars 1986
    Livré le 31 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8/10 stanley street liverpool.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 août 1983
    Livré le 30 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    39 bell street st andrews.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 août 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 19 août 1983
    Livré le 30 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    21- 25- reform street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 août 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 04 août 1983
    Livré le 15 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 août 1983Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 11 mai 1983
    Livré le 26 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by caird retail LTD
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Fourth supplementary bond of cash credit & disposition in security & addendum to agreement
    Créé le 31 oct. 1968
    Livré le 04 nov. 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £177,500
    Brèves mentions
    Capital, stocks, property funds assets and profits, shop premises and 17 policies of assurance on life.
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Life Assurance Company
    Transactions
    • 04 nov. 1968Enregistrement d'une charge
    • 13 janv. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 01 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    CAIRD GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 déc. 2016Commencement of winding up
    24 févr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0