DUMFRIES KNITWEAR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUMFRIES KNITWEAR LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC010939
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    9 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AL Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROBERTSON OF DUMFRIES LIMITED07 août 198707 août 1987
    J.A. ROBERTSON & SONS (DUMFRIES) LIMITED03 févr. 192003 févr. 1920

    Quels sont les derniers comptes de DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2002
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2003
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2001

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 juin 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Avis du rapport du séquestre

    7 pages3.5(Scot)

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    6 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    5 pages419a(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2001

    12 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed robertson of dumfries LIMITED\certificate issued on 28/12/01
    3 pagesCERTNM

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2000

    12 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 31 déc. 1999

    16 pagesAA

    Modifications à une charge flottante

    8 pages466(Scot)

    legacy

    5 pages410(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    8 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    8 pages466(Scot)

    legacy

    1 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution ordinaire d'augmentation du capital social autorisé

    ORES04

    legacy

    5 pages410(Scot)

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    4 pages88(3)

    legacy

    2 pages88(2)R

    Qui sont les dirigeants de DUMFRIES KNITWEAR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANGELINO, Stefano
    7 Viale Roma
    FOREIGN Biella
    Italy
    Administrateur
    7 Viale Roma
    FOREIGN Biella
    Italy
    Italian16138320001
    ANDERS, Jill
    Cherry Garth North Lane
    Wheldrake
    YO4 6BL York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Cherry Garth North Lane
    Wheldrake
    YO4 6BL York
    North Yorkshire
    British9506490001
    ANDERSON, David Mathieson
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    British551340001
    BUTLER, Alexander Lowe
    Mickledore
    Westlinton
    CA6 6AA Carlisle
    Cumbria
    Secrétaire
    Mickledore
    Westlinton
    CA6 6AA Carlisle
    Cumbria
    British51885840002
    CAVEN, Janet Mcminn
    79 Queen Street
    DG1 2JS Dumfries
    Dumfriesshire
    Secrétaire
    79 Queen Street
    DG1 2JS Dumfries
    Dumfriesshire
    British75795860001
    HAYWARD, Jeremy John Uphill
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    British802750001
    MCDOUGALL, Neil Mckenzie
    13 Livingstone Place
    DG11 2AU Lockerbie
    Dumfriesshire
    Secrétaire
    13 Livingstone Place
    DG11 2AU Lockerbie
    Dumfriesshire
    British17890840001
    STORR, Teresa Angela
    Tiggerdom Cottage
    Eastend Farm Marrick
    DW1 7LQ Richmond
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Tiggerdom Cottage
    Eastend Farm Marrick
    DW1 7LQ Richmond
    North Yorkshire
    British75808310001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, David Mathieson
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish551340001
    BARNES, Graham Leslie
    21 Egerton Drive
    SE10 8JR London
    Administrateur
    21 Egerton Drive
    SE10 8JR London
    British14145910001
    BUTLER, Alexander Lowe
    Mickledore
    Westlinton
    CA6 6AA Carlisle
    Cumbria
    Administrateur
    Mickledore
    Westlinton
    CA6 6AA Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritish51885840002
    BUTTERWORTH, Michael
    30 Bridgewater Drive
    LE8 9DX Great Glen
    Leicestershire
    Administrateur
    30 Bridgewater Drive
    LE8 9DX Great Glen
    Leicestershire
    British126604450001
    CHIOCCHETTI, Paolo
    Via Graglia 51
    13056 Occhieppo Sup Re(Bi)
    Italy
    Administrateur
    Via Graglia 51
    13056 Occhieppo Sup Re(Bi)
    Italy
    Italian43628870001
    FITTON, Neil Hamilton Livesey
    27 Guion Road
    SW6 4UD London
    Administrateur
    27 Guion Road
    SW6 4UD London
    British551350001
    GIBSON, Derek
    19 Urquhart Crescent
    DG1 4XF Dumfries
    Dumfriesshire
    Administrateur
    19 Urquhart Crescent
    DG1 4XF Dumfries
    Dumfriesshire
    British551360001
    HAYWARD, Jeremy John Uphill
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Spylaw Park
    Colinton
    EH13 0LP Edinburgh
    Midlothian
    British802750001
    KENNON, Gerald
    18
    Rowan Drive
    DG2 0NJ Dumfries
    Administrateur
    18
    Rowan Drive
    DG2 0NJ Dumfries
    British40470130002
    MCCLURE, Hugh Walpole
    31 Primrose Street
    DG2 7AU Dumfries
    Dumfriesshire
    Administrateur
    31 Primrose Street
    DG2 7AU Dumfries
    Dumfriesshire
    British551370001
    MCDOUGALL, Neil Mckenzie
    13 Livingstone Place
    DG11 2AU Lockerbie
    Dumfriesshire
    Administrateur
    13 Livingstone Place
    DG11 2AU Lockerbie
    Dumfriesshire
    British17890840001
    ROBERTSON, James
    31 Birkbeck Road
    SW19 8NZ London
    Administrateur
    31 Birkbeck Road
    SW19 8NZ London
    British51900350001
    SHEFFIELD, Peter John Kirkham
    Blyndley 30 Manse Street
    TD1 1NE Galashiels
    Selkirkshire
    Administrateur
    Blyndley 30 Manse Street
    TD1 1NE Galashiels
    Selkirkshire
    British56329360001
    THOMSON, Christopher Norman
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish11591540001
    WINTER, Richard Terence
    2 Doria Road
    SW6 4UG London
    Administrateur
    2 Doria Road
    SW6 4UG London
    British16138260001
    WOMBY, Frank
    Auchengrane
    DG7 2LH Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Auchengrane
    DG7 2LH Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    British551380001

    DUMFRIES KNITWEAR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 25 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Saughtree factory, bellvue street, dumfries.
    Personnes ayant droit
    • Z Hinchliffe & Sons Limited
    Transactions
    • 25 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 août 2000
    Livré le 08 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Z.Hinchcliffe & Sons Limited
    Transactions
    • 08 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1997
    Livré le 10 juil. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Elba International S.P.A
    Transactions
    • 10 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 nov. 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
      • Numéro de dossier 1
    Bond & floating charge
    Créé le 21 févr. 1996
    Livré le 23 févr. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due by drumohr holdings limited
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Elba International S.P.A.
    Transactions
    • 23 févr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mars 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 25 oct. 1994
    Livré le 28 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by drumohr holdings limited
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Elba International S.P.A.
    Transactions
    • 28 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 oct. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 mars 1992
    Livré le 11 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Saughtree factory, belle vue street, dumfries.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 28 janv. 1992
    Livré le 03 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank Plkc
    Transactions
    • 03 févr. 1992Enregistrement d'une charge
    • 28 oct. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    DUMFRIES KNITWEAR LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juil. 1997Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Michael Hall
    Bkr Haines Watts
    9 Coates Crescent
    EH3 7AL Edinburgh
    practitioner
    Bkr Haines Watts
    9 Coates Crescent
    EH3 7AL Edinburgh
    Ian William Wright
    9 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AL
    practitioner
    9 Coates Crescent
    Edinburgh
    EH3 7AL
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0