FERNBRAE HOSPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFERNBRAE HOSPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC011950
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    • (8511) /
    • (8512) /
    • (8513) /

    Où se situe FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ross Hall Hospital
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FERNBRAE PRIVATE CLINIC (DUNDEE) LIMITED24 nov. 192124 nov. 1921

    Quels sont les derniers comptes de FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return01 août 2008

    legacy

    363(353)

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Transaction documents approve 27/03/2008
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amendment agreement 27/03/2008
    RES13

    Comptes établis au 30 sept. 2007

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    13 pagesAA

    legacy

    12 pages410(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    legacy

    10 pages155(6)a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    8 pages410(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    10 pages155(6)a

    legacy

    10 pages155(6)a

    Qui sont les dirigeants de FERNBRAE HOSPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COLLIER, Stephen John
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    Secrétaire
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    British18350160001
    COLLIER, Stephen John
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    Administrateur
    180 Kennington Park Road
    Kennington
    SE11 4BT London
    United KingdomBritish18350160001
    WIELAND, Phil
    Clodhouse Hill
    Worplesdon Hill
    GU22 0QS Woking
    Sixpenny Buckle
    Surrey
    Administrateur
    Clodhouse Hill
    Worplesdon Hill
    GU22 0QS Woking
    Sixpenny Buckle
    Surrey
    EnglandBritish119448000002
    LOGGIE, Henderson
    Royal Exchange Building
    Panmure Street
    DD1 1DZ Dundee
    Angus
    Secrétaire
    Royal Exchange Building
    Panmure Street
    DD1 1DZ Dundee
    Angus
    British69918590001
    RUSSELL, Ronald
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    Secrétaire
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    Scottish9221920003
    AULD, Charles Cairns
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    Administrateur
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    United KingdomBritish23257420003
    BONAR, George Christopher
    St Kitts 24 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NT Dundee
    Angus
    Administrateur
    St Kitts 24 Albany Road
    Broughty Ferry
    DD5 1NT Dundee
    Angus
    ScotlandBritish410910001
    BONAR, Ronald Jonathan
    Inniscarra
    DD1 Dundee
    Administrateur
    Inniscarra
    DD1 Dundee
    British26178320001
    CHAPPELL, Derek Guy
    43 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    Administrateur
    43 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    British32697520003
    CROWDER, Anne M
    2 Rosemarkie Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 2RQ Dundee
    Angus
    Administrateur
    2 Rosemarkie Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 2RQ Dundee
    Angus
    British423270001
    CUNNINGHAM, Susan Anne
    20 Argyll Place
    AB2 4EL Aberdeen
    Administrateur
    20 Argyll Place
    AB2 4EL Aberdeen
    British39591020001
    HAYES, Eugene Gerard
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    Administrateur
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    Irish2464310004
    JOHNSTONE, Robert
    Fraocho 53 Riverside Road
    Wormit
    DD6 8LL Newport On Tay
    Fife
    Administrateur
    Fraocho 53 Riverside Road
    Wormit
    DD6 8LL Newport On Tay
    Fife
    British47555910003
    JOHNSTONE, Robert
    21 Viewforth Gardens
    EH10 4ET Edinburgh
    Administrateur
    21 Viewforth Gardens
    EH10 4ET Edinburgh
    British47555910001
    LYALL, Michael Hodge
    "Davaar" 26 Linden Avenue
    DD6 8DU Newport On Tay
    Fife
    Administrateur
    "Davaar" 26 Linden Avenue
    DD6 8DU Newport On Tay
    Fife
    British1098710001
    MURPHY, Paul
    Cunnery Farm Wychnor Park
    Burton-Under-Needwood
    DE13 8BU Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Cunnery Farm Wychnor Park
    Burton-Under-Needwood
    DE13 8BU Burton Upon Trent
    Staffordshire
    British103319780001
    NEWTON, Ray W, Dr
    70 Seafield Road
    Broughty Ferry
    DD5 3AQ Dundee
    Angus
    Administrateur
    70 Seafield Road
    Broughty Ferry
    DD5 3AQ Dundee
    Angus
    British17201770001
    RUSSELL, Ronald
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    Administrateur
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    ScotlandScottish9221920003
    RUSSELL, Sandra
    55 Anderson Drive
    AB1 6UA Aberdeen
    Administrateur
    55 Anderson Drive
    AB1 6UA Aberdeen
    British39591110001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    Administrateur
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritish110396210002
    WALKER, William F
    438 Blackness Road
    DD2 1TQ Dundee
    Angus
    Administrateur
    438 Blackness Road
    DD2 1TQ Dundee
    Angus
    British423260001

    FERNBRAE HOSPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 09 oct. 2006
    Livré le 25 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 09 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 05 août 1999
    Livré le 11 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fernbrae private clinic, 329 perth road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transactions
    • 11 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 août 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 24 août 1995
    Livré le 06 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fernbrae private clinic, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 août 1995
    Livré le 25 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 août 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 05 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fernbrae private clinic, perth road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • George Christopher Bonar
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juin 1992
    Livré le 22 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • George Christopher Bonar
    Transactions
    • 22 juin 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juil. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 juil. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 19 juin 1989
    Livré le 22 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Matrons's house fernbrae dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 02 juin 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 30 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 avr. 1989
    Livré le 25 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 août 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0