WYLIE'S LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWYLIE'S LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC012653
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WYLIE'S LIMITED ?

    • (5010) /

    Où se situe WYLIE'S LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WYLIE'S LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2002
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2003
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WYLIE'S LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 févr. 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation03 mars 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WYLIE'S LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour WYLIE'S LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis du rapport du séquestre

    8 pages3.5(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    6 pages1(Scot)

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    5 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 déc. 2000

    17 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 1999

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Modifications à une charge flottante

    17 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    11 pages466(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de WYLIE'S LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Secrétaire
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    BritishAccountant62414920001
    CARLAW, David Jackson
    2 Otterburn Drive
    Giffnock
    G46 6UJ Glasgow
    Administrateur
    2 Otterburn Drive
    Giffnock
    G46 6UJ Glasgow
    BritishMotor Vehicle Dealer233820002
    MACKENZIE, Alan Lovat
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    Administrateur
    8 Roxburgh Drive
    Bearsden
    G61 3LH Glasgow
    ScotlandBritishAccountant62414920001
    STEVENSON, Thomas Tennant
    84 Doonfoot Road
    KA7 4DP Ayr
    Ayrshire
    Secrétaire
    84 Doonfoot Road
    KA7 4DP Ayr
    Ayrshire
    British233780001
    AITKEN, William Munro
    Lowhill House Mews
    Eaglesham
    G76 0NU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Lowhill House Mews
    Eaglesham
    G76 0NU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMotor Vehicle Dealer251330002
    ANDERSON, Alexander
    45 Beechlands Drive
    Clarkston
    G76 7UZ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Beechlands Drive
    Clarkston
    G76 7UZ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMotor Vehicle Dealer759750001
    CARLAW, Ian Alexander
    4 Kirkvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5HD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Kirkvale Drive
    Newton Mearns
    G77 5HD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMotor Vehicle Dealer233790001
    CARLAW, Raine Alexander
    17 Bruce Road
    G41 5EE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    17 Bruce Road
    G41 5EE Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMarketing Executive65943660001
    GRANT, Peter Alexander
    12 Netherton Road
    G77 6ER Glasgow
    Administrateur
    12 Netherton Road
    G77 6ER Glasgow
    ScotlandBritishMotor Vehicle Dealer121468020001
    HOLLINS, Philip James
    243 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    Administrateur
    243 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    BritishManager68894660001
    MCDONALD, David Robert
    30 Springkell Drive
    G41 4EZ Glasgow
    Administrateur
    30 Springkell Drive
    G41 4EZ Glasgow
    BritishMotor Vehicle Dealer38494420001
    MCGRATH, Brian
    14 Hamilton Drive
    Cambuslang
    G72 8JG Glasgow
    Administrateur
    14 Hamilton Drive
    Cambuslang
    G72 8JG Glasgow
    BritishMotor Dealer43304640001
    MCKENZIE, Ian
    47 Cartsbridge Road
    G76 8DH Busby
    Glasgow
    Administrateur
    47 Cartsbridge Road
    G76 8DH Busby
    Glasgow
    BritishMotor Vehicle Dealer38766390001
    PATRICK, Alan Armstrong
    2
    Blackfaulds Drive
    KA3 6EJ Fenwick
    Ayrshire
    Administrateur
    2
    Blackfaulds Drive
    KA3 6EJ Fenwick
    Ayrshire
    BritishAutomotive Manager58570520001
    ROSS, Colin Leslie
    Sunnyside Cottage
    Goose Green
    EH31 2RT Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Sunnyside Cottage
    Goose Green
    EH31 2RT Gullane
    East Lothian
    BritishPersonnel Management450300002
    STEVENSON, Thomas Tennant
    84 Doonfoot Road
    KA7 4DP Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    84 Doonfoot Road
    KA7 4DP Ayr
    Ayrshire
    BritishChartered Accountant233780001
    STEWART, Gordon
    38 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    38 Broomfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5JP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMotor Dealer1004540001
    STIRLING, Norman James
    1 Lethame Gardens
    ML10 6DF Strathaven
    Administrateur
    1 Lethame Gardens
    ML10 6DF Strathaven
    BritishOperations Director55947030001
    WILSON, Jane Deborah
    Flat 1r 46 Walton Street
    G41 3LS Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    Flat 1r 46 Walton Street
    G41 3LS Glasgow
    Strathclyde
    BritishMarketing Executive59915400001
    WYLIE, Alastair James Blair
    17 Fotheringay Road
    G41 4NL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    17 Fotheringay Road
    G41 4NL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishMotor Vehicle Dealer609190001

    WYLIE'S LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 13 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 nov. 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 07 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 2002Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 17 janv. 2007Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • 125 janv. 2014Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
      • Numéro de dossier 1
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 07 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All new and used motor vehicles of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 07 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 mai 2000
    Livré le 20 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Garage and showroom premises at gibshill road & pottery street and port glasgow road, greenock.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 20 mai 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 muirhead road, cumbernauld.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 févr. 2000
    Livré le 03 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at gibshill road and pottery street, greenock.
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 févr. 2000
    Livré le 29 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot d, site 2 at cambuslang investment park, lanark road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 29 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 déc. 1998
    Livré le 06 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Sites at eaglesham road,east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • Fce Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All used motor vehicles....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 nov. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 15 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All new motor vehicles....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 nov. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 15 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ford Credit Europe PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 nov. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 11 janv. 1993
    Livré le 22 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    370 pollokshaws road glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 22 janv. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 nov. 1991
    Livré le 06 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.86 acres at 1000 kennishead road, glasgow 2.910 acres at kilbirnie street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 déc. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond and assignation
    Créé le 16 mai 1991
    Livré le 28 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies due by ford motor credit company LTD to the company.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transactions
    • 28 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 26 janv. 1982
    Livré le 04 févr. 1982
    En cours
    Montant garanti
    £300,000
    Brèves mentions
    All the right title and interest of wylies LTD.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company LTD
    Transactions
    • 04 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 22 mai 1980
    Livré le 29 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole the subjects containing 2.655 acres of ground at junction of dinmont road and durnard avenue, glasgow with the whole buildings and other erections thereon.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 29 mai 1980Enregistrement d'une charge
    • 20 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation in security
    Créé le 18 juin 1977
    Livré le 07 juil. 1977
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Initial sum of £347,366 and all monies due or to become due in terms of s o r agreement between the company and ford motor credit company limited dated 01-09-1977.
    Personnes ayant droit
    • Ford Motor Credit Company LTD
    Transactions
    • 07 juil. 1977Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 17 avr. 1973
    Livré le 25 avr. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 25 avr. 1973Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 févr. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 mars 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 mars 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    WYLIE'S LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 août 2000Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Ruddock
    Grant Thornton Ca
    The Explorer Building
    RH10 9GT Fleming Way
    Manor Royal Crawley,
    practitioner
    Grant Thornton Ca
    The Explorer Building
    RH10 9GT Fleming Way
    Manor Royal Crawley,
    Matthew Purdon
    Grant Thornton Ws
    The Explorer Building
    RH10 9GT Fleming Way
    Manor Royal Crawley,
    practitioner
    Grant Thornton Ws
    The Explorer Building
    RH10 9GT Fleming Way
    Manor Royal Crawley,
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    31 août 2000Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Purdon Henderson
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Nigel Ruddock
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    practitioner
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0