ROK ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROK ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC013685
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROK ESTATES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe ROK ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    151 St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROK ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CITY ESTATES LIMITED26 mai 192526 mai 1925

    Quels sont les derniers comptes de ROK ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ROK ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Julian Turnbull en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sandra Al-Kordi en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2010

    État du capital au 26 mai 2010

    • Capital: GBP 171,666
    SH01

    Nomination de Mr Julian Patrick Turnbull en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Sandra Joan Al-Kordi en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Julian Turnbull en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ross Christie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Garvis Snook en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    21 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 53

    10 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 50

    13 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 51

    16 pages466(Scot)

    legacy

    14 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 52

    10 pages466(Scot)

    legacy

    13 pages410(Scot)

    legacy

    8 pages410(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    25 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de ROK ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AL-KORDI, Sandra Joan
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    150343640001
    LEICESTER, John William
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    British1011450001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    British5814050002
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    British80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Secrétaire
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    WHITEHEAD, John
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    Secrétaire
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    British546830001
    BAILEY, Michael William John
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    Administrateur
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    British104839850001
    BRYAN, Richard Hugh
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    British1011430001
    CHRISTIE, Ross Arneil
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish106468680002
    CRAIG, Brian Archibald
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish71144000001
    GIDNEY, David Guy
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    British63635850001
    GLOVER, Edward Douglas
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    Administrateur
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    United KingdomBritish121380002
    HOLE, Nicholas Ian
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    Administrateur
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    United KingdomBritish128347270001
    JORDAN, Rodney Beeching
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    Administrateur
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    British76263960001
    KAY, Mark Russell
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Administrateur
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    British1472550001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    British5814050002
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    British5814050001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Irish11264820004
    MALLINSON, David John
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    Administrateur
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    British24343760001
    REARDON, David James
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    Administrateur
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    British50574050001
    SNOOK, Garvis David
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    Administrateur
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    EnglandBritish70647210004
    TEMPEST, Philip Anthony
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    Administrateur
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    British36898820003
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    British80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Administrateur
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    EnglandEnglish11548360002

    ROK ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture and guarantee
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 31 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Temple Trustees Limited
    Transactions
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 28 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Temple Trustees Limited
    Transactions
    • 28 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture and guarantee
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Third party legal charge
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 22 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over plot 4400, solent business park, fareham, hampshire; fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over shares
    Créé le 20 juin 1997
    Livré le 27 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The shares.
    Personnes ayant droit
    • Mckay Securities PLC
    Transactions
    • 27 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over shares
    Créé le 20 juin 1997
    Livré le 27 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All shares.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transactions
    • 27 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of assignment
    Créé le 13 déc. 1996
    Livré le 30 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rights,title and interest to one third of the entitlement.
    Personnes ayant droit
    • Eastern Rivers Limited
    Transactions
    • 30 déc. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 04 déc. 1995
    Livré le 12 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 carlton crescent, southampton, registered under title number hp 101992, together with all covenants and rights, plant, machinery etc., and goodwill in relation to that property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 16 août 1995
    Livré le 31 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First legal mortgage on plot 300, ancells business park, fleet, hampshire, registered under title number hp 321407, assignment of the benefit of all leases on that property, and first fixed charges on goodwill and any vat relating to the property.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transactions
    • 31 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 juil. 1995
    Livré le 04 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of assignment and charge
    Créé le 23 mai 1995
    Livré le 12 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 300, ancells business park, fleet, hampshire...... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transactions
    • 12 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 21 mars 1995
    Livré le 10 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1) legal mortgage on the sun inn, town quay, southampton, registered under title number HP454183 2) assignment of security on all present and future derivative leases 3) fixed charge on goodwill 4) fixed charge on rights in any monies representing repayment by custon & excise of vat.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge
    Créé le 30 janv. 1995
    Livré le 16 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See continuation sheet no.2 On c/hse microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transactions
    • 16 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 janv. 1995
    Livré le 15 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See scheldule 2 on c/hse microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Property Investments Limited
    Transactions
    • 15 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 10 févr. 1994
    Livré le 16 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 carlton crescent, southampton and registered at H.M. land registry HP101992.
    Personnes ayant droit
    • Clerical Medical and General Life Assurance Society
    Transactions
    • 16 févr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 1992
    Livré le 24 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 carlton crescent southampton,hp 101992.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 janv. 1992Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 09 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 22 avr. 1991
    Livré le 30 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 2 haywards business centre new lane havant hampshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 1990
    Livré le 04 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as or being land having frontage to brunel road and telford road, salisbury, wiltshire comprising of 2.6 acres.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    Mortgage deed
    Créé le 08 sept. 1989
    Livré le 25 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £300,000
    Brèves mentions
    5 carlton crescent southampton hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Alliance & Leicester Building Society
    Transactions
    • 25 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 11 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 1989
    Livré le 06 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property west side of castle way southampton hampshire title no hp 293934.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    First legal charge
    Créé le 21 févr. 1989
    Livré le 06 mars 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Aerogan works, newmans lane, alton in hampshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mars 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1989
    Livré le 06 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    385 wimbourne rd., Winton, bournemouth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 11 janv. 1989
    Livré le 16 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 carlton crescent, southampton, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1988
    Livré le 13 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Piece of land on north side of the hundred ramsey, hampshire plus shop at 28 the hundred ramsey.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 04 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0