FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC

FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC013958
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    50 Lothian Road
    Festival Square, Edinburgh
    EH3 9WJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FINSBURY GROWTH TRUST PLC29 avr. 199229 avr. 1992
    SCOTTISH CITIES INVESTMENT TRUST PLC15 janv. 192615 janv. 1926

    Quels sont les derniers comptes de FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2027
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 janv. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 janv. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 janv. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    15 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2025

    108 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 24,168,230
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 23,784,921.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 nov. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 23,457,421.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 nov. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 23,153,588.75
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    07 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 22,625,322.5
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 22,858,509.5
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 22,318,978
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 22,028,782.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,745,107.5
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,555,932.5
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,384,705
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 juil. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,276,915
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 juin 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,010,398.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 juin 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 21,200,594.25
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 juin 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 20,971,219.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    27 mai 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 20,679,754
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    16 mai 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 20,349,535.75
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 19,907,927.25
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 20,172,134.75
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 19,801,828.25
    4 pagesSH03

    Qui sont les dirigeants de FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FROSTROW CAPITAL LLP
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Secrétaire
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementOC323835
    121077800002
    ASHTON, James Robert
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish275413170001
    CORNISH-BOWDEN, Kate
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    United KingdomBritish117949200002
    KELLY, Sandra Claire
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25 Southampton Buildings
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25 Southampton Buildings
    England
    EnglandBritish263221580001
    PUREWAL, Parwinder Singh
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    England
    EnglandBritish302712990002
    TILBIAN, Lorna Mona
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritish44049090001
    FARRAR, John William Lovat
    116 Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 3EQ London
    Secrétaire
    116 Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 3EQ London
    British41946740001
    SPIVEY, Hilary
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    Secrétaire
    52 Friars Street
    CO10 6AG Sudbury
    Suffolk
    British1846560001
    CLOSE FINSBURY ASSET MANAGEMENT LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Secrétaire
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    70688480002
    CLOSE INVESTMENTS LIMITED
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    Secrétaire
    10 Crown Place
    EC2A 4FT London
    117475800001
    REA BROTHERS LIMITED
    12 Appold Street
    EC2A 2AW London
    Secrétaire
    12 Appold Street
    EC2A 2AW London
    26633510002
    ALLARD, John Peter
    Frome Farm
    BS37 6LU Old Sodbury
    South Gloucestershire
    Administrateur
    Frome Farm
    BS37 6LU Old Sodbury
    South Gloucestershire
    EnglandBritish5923120001
    BECKMAN, Johan Bengt Yngve
    40 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Administrateur
    40 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Swedish3479000003
    BRUNDIN, Clark Lannerdahl, Dr
    28 Observatory Street
    OX2 6EW Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    28 Observatory Street
    OX2 6EW Oxford
    Oxfordshire
    British5839640005
    COLLINS, Neil Adam
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    Administrateur
    12 Gertrude Street
    SW10 0JN London
    EnglandBritish115908170001
    EARL OF DARTMOUTH, Gerald Humphrey
    48 Grosvenor Square
    W1X 9AB London
    Administrateur
    48 Grosvenor Square
    W1X 9AB London
    British291710001
    HARTLEY, Walter Otto
    221 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    Administrateur
    221 Sussex Gardens
    W2 2RL London
    British1846580001
    HAYES, Simon
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    Administrateur
    Southampton Buildings
    WC2A 1AL London
    25
    United KingdomBritish199638480001
    HUNT, David Charles
    Poplar Cottage
    Coupton
    GU3 1JF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Poplar Cottage
    Coupton
    GU3 1JF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish23176270001
    NAIRNE, Patrick Dalmahoy, Sir
    Yew Tree
    Chilson
    OX7 3HU Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Yew Tree
    Chilson
    OX7 3HU Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritish27781040001
    REEVE, Michael Arthur Ferard
    138 Oakwood Court
    W14 8JL London
    Administrateur
    138 Oakwood Court
    W14 8JL London
    United KingdomBritish3478970001
    RENWICK, Vanessa
    38 Wandle Road
    Wandsworth
    SW17 7DW London
    Administrateur
    38 Wandle Road
    Wandsworth
    SW17 7DW London
    EnglandBritish72764200001
    TOWNSEND, John Anthony Victor
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish97263430005
    TOWNSEND, John Anthony Victor
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    The Coach House, Winterfold
    Barhatch Lane
    GU6 7NH Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish97263430005
    URRY, Stewart Wallace
    Ashley Chase House
    Abbotsbury
    DT3 4JZ Weymouth
    Dorset
    Administrateur
    Ashley Chase House
    Abbotsbury
    DT3 4JZ Weymouth
    Dorset
    United KingdomBritish8682110002
    WARMAN, Giles William Buckland
    111 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    Administrateur
    111 Clifton Hill
    NW8 0JS London
    EnglandBritish770520002

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0