MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED

MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC013989
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Computershare Investor Services
    Plc, Lochside House
    EH12 9DJ 7 Lochside Avenue, Edinburgh
    Park, Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLINSON, Bernadette
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Secrétaire
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Other116264270002
    DALGAARD, Flemming
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomDanish116091010001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Administrateur
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    EnglandBritish30168510002
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Administrateur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WOOLLACOTT, John Mark
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Administrateur
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Australian121666370002
    CUNNINGHAM, Charles Howard
    50 Bathgate Road
    SW19 5PJ London
    Secrétaire
    50 Bathgate Road
    SW19 5PJ London
    British1095260001
    DAMLE, Sameer Dileep
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    Secrétaire
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    British121281830001
    DENCHFIELD, Michael David
    Mount Pleasant
    Chediston
    IP19 Halesworth
    Suffold
    Secrétaire
    Mount Pleasant
    Chediston
    IP19 Halesworth
    Suffold
    British12732130001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Secrétaire
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    British30168510002
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    British10057640001
    REES, Nicholas Haydn Glyndwr
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    Secrétaire
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    British115881230001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Secrétaire
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    British75631110001
    CROSSMAN, John Malcolm, Lieutenant Commander
    The Old Vicarage
    Church Hill Ramsey
    CO12 5EU Harwich
    Essex
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Church Hill Ramsey
    CO12 5EU Harwich
    Essex
    EnglandBritish41093970001
    CUNNINGHAM, Charles Howard
    50 Bathgate Road
    SW19 5PJ London
    Administrateur
    50 Bathgate Road
    SW19 5PJ London
    British1095260001
    DENCHFIELD, Michael David
    Mount Pleasant
    Chediston
    IP19 Halesworth
    Suffold
    Administrateur
    Mount Pleasant
    Chediston
    IP19 Halesworth
    Suffold
    British12732130001
    DUNLOP, Graeme Dermott Stuart
    Baylisden House
    Bethersden
    TN26 3EY Kent
    Administrateur
    Baylisden House
    Bethersden
    TN26 3EY Kent
    British429340001
    GRADON, Richard Michael
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish48859920002
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritish8207040001
    MONTEITH, Nicholas John
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    British39120850002
    MOORE, Michael Ellis
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    American114436710001
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    British10057640001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Administrateur
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    EnglandBritish75631110001
    SHAW, Derek
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    Administrateur
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    EnglandBritish114437060001
    WALTERS, Patrick William
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    Administrateur
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    EnglandBritish154424260001

    MONARCH STEAMSHIP COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    1ST priority statutory mortgage
    Créé le 01 mai 1986
    Livré le 14 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64 shares of and in the M.V. "baltic ferry" reg'd port of london official no. 379708.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank PLC and Another
    Transactions
    • 14 mai 1986Enregistrement d'une charge
    1ST priority statutory mortgage
    Créé le 01 mai 1986
    Livré le 14 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64 shares of and in the M.V. "nordic ferry" regd port of london official no 379667.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank PLC and Another
    Transactions
    • 14 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 23 avr. 1986
    Livré le 12 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The motor vessel "nordic ferry" and all the company's interest in the vessel.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank PLC and Another
    Transactions
    • 12 août 1986Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 23 avr. 1986
    Livré le 12 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The motor vessel "baltic ferry" and all the company's interest in the vessel.
    Personnes ayant droit
    • International Westminster Bank PLC and Another
    Transactions
    • 12 mai 1986Enregistrement d'une charge
    Statutory mortgage
    Créé le 22 oct. 1985
    Livré le 28 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by larne harbour LTD
    Brèves mentions
    64/64TH shares of and in M.V. "european enterprise".
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Bremen
    Transactions
    • 28 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    Deed
    Créé le 22 oct. 1985
    Livré le 28 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by larne harbour LTD
    Brèves mentions
    M.V. "european enterprise" all the company's interest in the vessel.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Bremen
    Transactions
    • 28 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 17 nov. 1980
    Livré le 04 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    D. fl. 7360,000 & all sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the motor vessel "european gateway" registered under official no. 363725.
    Personnes ayant droit
    • N V Export Financiering Maatschappij
    Transactions
    • 04 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    Statutory mortgage
    Créé le 17 nov. 1980
    Livré le 04 déc. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the vessel M.V. "european gateway" nos 363725.
    Personnes ayant droit
    • N V Export Financiering Maatschappij
    Transactions
    • 04 déc. 1980Enregistrement d'une charge
    Letter of set-off
    Créé le 29 août 1978
    Livré le 08 sept. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1978Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mutual letter
    Créé le 29 août 1978
    Livré le 08 sept. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank LTD.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 08 sept. 1978Enregistrement d'une charge
    • 15 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 28 avr. 1978
    Livré le 09 mai 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company and or european ferries LTD
    Brèves mentions
    All the charge's rights, title and interest in an to motor vessel "european enterprise".
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 09 mai 1978Enregistrement d'une charge
    Statutory mortgage
    Créé le 28 avr. 1978
    Livré le 09 mai 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from the company and/or european ferries LTD
    Brèves mentions
    64 64TH shares in "european enterprise no 362879.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Aktienge Sellschaft
    Transactions
    • 09 mai 1978Enregistrement d'une charge
    Deed of covenant
    Créé le 13 mai 1976
    Livré le 18 mai 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing dkr £104,800,000 all sums due or to become due
    Brèves mentions
    The above vessel's insurances earnings etc.
    Personnes ayant droit
    • Aktieselekabet Dansk Skibsfinanslering
    Transactions
    • 18 mai 1976Enregistrement d'une charge
    Statutory mortgage
    Créé le 13 mai 1976
    Livré le 18 mai 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64 shares in viking viscount.
    Personnes ayant droit
    • Aktieselekabet Dansk Skibsflnanslering
    Transactions
    • 18 mai 1976Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0