GH REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGH REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC014090
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GH REALISATIONS LIMITED ?

    • (2222) /

    Où se situe GH REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    162 Leith Walk
    Edinburgh
    EH6 5DX
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GH REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GREENAWAY HARRISON LIMITED02 avr. 199602 avr. 1996
    PILLANS AND WILSON SPECIALIST LITHO PRINTERS LIMITED01 févr. 198901 févr. 1989
    WILLIAM BLACKWOOD & SONS LIMITED01 avr. 192601 avr. 1926

    Quels sont les derniers comptes de GH REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 1998

    Quels sont les derniers dépôts pour GH REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    4 pages3(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    4 pages3(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    4 pages3(Scot)

    Avis du rapport du séquestre

    13 pages3.5(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed greenaway harrison LIMITED\certificate issued on 01/09/99
    pagesCERTNM

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    6 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    8 pages1(Scot)

    Modifications à une charge flottante

    8 pages466(Scot)

    legacy

    6 pages410(Scot)

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363s

    Comptes annuels établis au 02 janv. 1998

    23 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    0 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    0 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 1996

    21 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GH REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HILDER, Mark Alan Christopher
    34 Ridgeway
    Hayes
    BR2 7DE Bromley
    Kent
    Secrétaire
    34 Ridgeway
    Hayes
    BR2 7DE Bromley
    Kent
    British51917250001
    CARGILL, Alexander Ray
    15 Galachlawside
    EH10 7JG Edinburgh
    Secrétaire
    15 Galachlawside
    EH10 7JG Edinburgh
    British48562870002
    CURRAN, John Paul
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Secrétaire
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    British44316690001
    GILLIAT-SMITH, Mathew Jolyon
    6 Burland Road
    Battersea
    SW11 6SA London
    Secrétaire
    6 Burland Road
    Battersea
    SW11 6SA London
    British51920020001
    HOLMES, Terence Henry
    140 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    140 Craiglea Drive
    EH10 5PR Edinburgh
    Midlothian
    British527070001
    ROWLAND, Philip James
    Waters Place
    SW15 1LH London
    2
    Secrétaire
    Waters Place
    SW15 1LH London
    2
    British130589800001
    TAYLOR, Donald
    1 Spruce Avenue
    ML3 7NQ Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    1 Spruce Avenue
    ML3 7NQ Hamilton
    Lanarkshire
    British778360001
    BOWSTEAD, Graham John
    14 Mavisbank
    KY13 8QR Kinross
    Kinross-Shire
    Administrateur
    14 Mavisbank
    KY13 8QR Kinross
    Kinross-Shire
    British1175630002
    CARGILL, Alexander Ray
    15 Galachlawside
    EH10 7JG Edinburgh
    Administrateur
    15 Galachlawside
    EH10 7JG Edinburgh
    British48562870002
    CURRAN, John Paul
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Administrateur
    Strathearn 29 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    ScotlandBritish44316690001
    FAIRBAIRN, James David Lawson
    8 Glenlockhart Bank
    EH14 1BL Edinburgh
    Administrateur
    8 Glenlockhart Bank
    EH14 1BL Edinburgh
    British73069530001
    GIBSON, Ian Scott
    18 Crummock Gardens
    KA15 2HD Beith
    Ayrshire
    Administrateur
    18 Crummock Gardens
    KA15 2HD Beith
    Ayrshire
    British175670001
    GORDON, Anthony John
    6 The Chipping
    GL8 8ET Tetbury
    Gloucestershire
    Uk
    Administrateur
    6 The Chipping
    GL8 8ET Tetbury
    Gloucestershire
    Uk
    British51887660002
    HILDER, Mark Alan Christopher
    34 Ridgeway
    Hayes
    BR2 7DE Bromley
    Kent
    Administrateur
    34 Ridgeway
    Hayes
    BR2 7DE Bromley
    Kent
    British51917250001
    HODGSON, Robert James
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    Administrateur
    The Hunting Lodge
    Wadhurst Park
    TN5 6NT Wadhurst
    East Sussex
    EnglandBritish54501880002
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Administrateur
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    MARTIN, Kevin
    1 Grub Reed Cottages
    TN6 3PX Highcross Rotherfield
    East Sussex
    Administrateur
    1 Grub Reed Cottages
    TN6 3PX Highcross Rotherfield
    East Sussex
    British72715130001
    ROWLAND, Philip James
    Waters Place
    SW15 1LH London
    2
    Administrateur
    Waters Place
    SW15 1LH London
    2
    EnglandBritish130589800001
    STEEL, John Scott Ferguson
    69 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    69 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British527090001
    WILSON, Graham Scott
    4 Belgrave Mews
    EH4 3AX Edinburgh
    Administrateur
    4 Belgrave Mews
    EH4 3AX Edinburgh
    British67618130001
    WINKS, Nicholas Paul David
    Greenways
    Battenhall Place
    WR5 2DT Worcester
    Administrateur
    Greenways
    Battenhall Place
    WR5 2DT Worcester
    United KingdomBritish63419280001

    GH REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 15 avr. 1999
    Livré le 06 mai 1999
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 06 mai 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 mai 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 25 sept. 1996
    Livré le 09 oct. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 oct. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 18 août 1999Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 13 oct. 2000Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • 213 avr. 2012Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
      • Numéro de dossier 2
    Bond & floating charge
    Créé le 18 juil. 1990
    Livré le 27 juil. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole assets under exception of lease of units, D.E.F. leith walk industrial estate edinburgh.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 août 1999Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 13 oct. 2000Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • 31 mai 2002Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
      • Numéro de dossier 1
    Floating charge
    Créé le 18 juil. 1990
    Livré le 26 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Under exception units def leith walk industrial estate edinburgh. Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • County Natwest Ventures Investments LTD
    Transactions
    • 26 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 mars 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Mandate
    Créé le 30 mars 1982
    Livré le 08 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Free sale proceeds of subjects, ground floor at 28/38 thistle street edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1982Enregistrement d'une charge

    GH REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 juil. 1990Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gordon Iain Bennet
    1 Blythswood Square
    Glasgow
    practitioner
    1 Blythswood Square
    Glasgow
    Alan Barrett
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    practitioner
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    25 sept. 1996Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gordon Iain Bennet
    1 Blythswood Square
    Glasgow
    practitioner
    1 Blythswood Square
    Glasgow
    Alan Barrett
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    practitioner
    Plumtree Court
    London
    EC4A 4HT
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0