JOHNSTON PRESS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOHNSTON PRESS PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC015382
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOHNSTON PRESS PLC ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JOHNSTON PRESS PLC ?

    Adresse du siège social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JOHNSTON PRESS PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    F. JOHNSTON & COMPANY LIMITED31 déc. 192831 déc. 1928

    Quels sont les derniers comptes de JOHNSTON PRESS PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour JOHNSTON PRESS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans une liquidation par le tribunal

    19 pagesWU15(Scot)

    Ordonnance du tribunal dans une liquidation (et pièce jointe de l'ordonnance du tribunal)

    6 pagesWU01(Scot)

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    2 pagesOC-DV

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Passage de l'administration à la dissolution

    34 pagesAM23(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    5 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10(Scot)

    Cessation de la nomination de Peter Mccall en tant que secrétaire le 17 mai 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David John King en tant que directeur le 17 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kjell Aamot en tant que directeur le 01 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 19 mars 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Guy Butterworth en tant que directeur le 19 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Camilla Alexandra Rhodes en tant que directeur le 09 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS à 272 Bath Street Glasgow G2 4JR le 06 déc. 2018

    2 pagesAD01

    Proposition de l'administrateur

    119 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    12 pages2.15B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    2 pages2.11B(Scot)

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Genera meeting of company called not less 14 clear days notice 05/06/2018
    RES13

    Qui sont les dirigeants de JOHNSTON PRESS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Secrétaire
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    British474360001
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146630180001
    AAMOT, Kjell
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    NorwayNorwegian153114510002
    BELL, Iain William
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    British35563110001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Administrateur
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    BUCHAN, William James
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    EnglandBritish232628330001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish76600500002
    CAMMIADE, Danny
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    EnglandBritish251394160001
    CAWDRON, Peter Edward Blackburn
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandBritish166325310001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Administrateur
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Administrateur désigné
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    DUNN, Hugh John Ramsay
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    Administrateur
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    British328340001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Administrateur
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HALE, Matthew Joseph Hovey
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    Administrateur
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    British7129870001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    HINTON, Leslie Frank
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    Administrateur
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    British104267650003
    IDDISON, Geoff
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    United KingdomBritish148074460002
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    Administrateur
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    British328390002
    JOHNSTON, Henry Charles Marriott
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    British474380004
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    KING, Martina Ann
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Administrateur
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    British107699510001
    MARSHALL, Augustus Ralph
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    Administrateur
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    MalaysiaMalaysian16432070011
    MERRILLS, Austin
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    Administrateur
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    British529310002
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    PAIN, Mark Andrew
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish122498680001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Administrateur
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritish41614380002
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    PATTERSON, Gavin Echlin
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    Administrateur
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    British131233950001
    RHODES, Camilla Alexandra
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    British139644420001
    ROCHE, Henry John, Sir
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    Administrateur
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    British53613320001
    RUDD-JONES, Nicholas
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    British77152150002
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003
    THE LORD GORDON OF STRATHBLANE
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    Administrateur
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    British312680002
    VAN ROOYEN, Stephen John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish178722710001

    JOHNSTON PRESS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2014
    Livré le 04 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 04 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2014
    Livré le 04 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    The extent that title to the real property in northern ireland freehold tenure see form for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 04 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 16 juin 2014
    Livré le 24 juin 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch for Itself and as Security Agent
    Transactions
    • 24 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Security agreement
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 oct. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 28 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Supplemantal legal mortgage
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Kings road, bury st edmonds, suffolk P212269 SK200901; 10/11 union street, wisbech, cambridgeshire; 46 high street, grantham, lincolnshire LL85306; oundle road, woodston ind est, peterborough CB233925.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 28 août 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 oct. 2013Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 28 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Deposit agreement and cash deposit pledge
    Créé le 09 août 2005
    Livré le 23 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with clause 5.2.2. under the credit agreement
    Brèves mentions
    The company pledges and assigns the deposit account and the deposit and all the present and future rights, titles and benefit of the company in the deposit account and the deposit.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 août 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 avr. 2002
    Livré le 30 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 12 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 25 juin 1999
    Livré le 06 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 juil. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1996
    Livré le 19 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself and as Trustee for Others
    Transactions
    • 19 juil. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 oct. 1978
    Livré le 26 oct. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 oct. 1978Enregistrement d'une charge
    • 11 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    JOHNSTON PRESS PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 nov. 2018Administration started
    15 juin 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    2
    DateType
    09 mars 2023Conclusion of winding up
    19 mai 2021Petition date
    11 juil. 2023Due to be dissolved on
    19 mai 2021Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    practitioner
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0