HANOVER FOUR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHANOVER FOUR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC015674
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HANOVER FOUR LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe HANOVER FOUR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HANOVER FOUR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THOMSON BROTHERS LTD.06 juin 199406 juin 1994
    THOMSON BROTHERS (KIRKCALDY) LIMITED16 août 192916 août 1929

    Quels sont les derniers comptes de HANOVER FOUR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 févr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour HANOVER FOUR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Mr Simon Terence Douglas en tant qu'administrateur le 14 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Hedley Bowcock en tant que directeur le 14 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 août 2011

    État du capital au 15 août 2011

    • Capital: GBP 21,412
    SH01

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Hedley Bowcock en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jayne Fearn en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 25 févr. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Marks en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Luminar Leisure Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 01 mars 2007

    7 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 02 mars 2006

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de HANOVER FOUR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158739440001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Administrateur
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03802937
    152179970001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secrétaire
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Administrateur
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Administrateur
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COOK, John
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    Administrateur
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    ScotlandBritish1388150003
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    GARVIE, David Campbell
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    British4668490001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    British6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    JUDGE, Michael
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    Administrateur
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    British653260001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MALCOLM, Alexander Ramsay
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    Administrateur
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    ScotlandBritish66254130001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Administrateur
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    PRENTICE, William
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    British653270001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Administrateur
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    HANOVER FOUR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 07 févr. 1995
    Livré le 23 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 16 août 1982
    Livré le 31 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by t s forster & sons LTD
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 août 1982Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 19 mars 1982
    Livré le 06 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by park naval engineering LTD
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 09 févr. 1981
    Livré le 13 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by robt. Balbirnie & company LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 févr. 1981Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 13 mars 1979
    Livré le 22 mars 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by fife forester LTD and/or others
    Brèves mentions
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by bank of scotland in name of thomson brothers (kirkcaldy) LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 mars 1979Enregistrement d'une charge
    • 06 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0