HANOVER FOUR LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HANOVER FOUR LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC015674 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HANOVER FOUR LIMITED ?
| Adresse du siège social | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow Lanarkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HANOVER FOUR LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 25 févr. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour HANOVER FOUR LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Terence Douglas en tant qu'administrateur le 14 nov. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Hedley Bowcock en tant que directeur le 14 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Hedley Bowcock en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Jayne Fearn en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 25 févr. 2010 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Marks en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Luminar Leisure Limited en tant qu'administrateur | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2009 | 8 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 28 févr. 2008 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes établis au 01 mars 2007 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 02 mars 2006 | 7 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 7 pages | 363s | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HANOVER FOUR LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEARN, Jayne | Secrétaire | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow Lanarkshire | 158739440001 | |||||||||||
| DOUGLAS, Simon Terence | Administrateur | Coopers Green Lane AL4 9HR St. Albans Oak House Hertfordshire England | England | British | 89567300002 | |||||||||
| LUMINAR LEISURE LIMITED | Administrateur | Deltic Avenue Rooksley MK13 8LW Milton Keynes Luminar House England |
| 152179970001 | ||||||||||
| ARMSTRONG, Colin North | Secrétaire | Barton End Priors Barton SO23 9QF Winchester Hampshire | British | 172030620001 | ||||||||||
| DACRE, Ronald Robert Hugh | Secrétaire | 21 Keirsbeath Court Kingseat KY12 0UE Dunfermline Fife | British | 813060001 | ||||||||||
| LIVINGSTONE, Peter Wishart | Secrétaire | 12 Normand Road Dysart KY1 2XJ Kirkcaldy Fife | British | 110527270001 | ||||||||||
| MACLEOD, Brian | Secrétaire | 18 Scobie Place KY12 7RX Dunfermline Fife | British | 43111330001 | ||||||||||
| MORRIS, David Charles | Secrétaire | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | 98815770001 | ||||||||||
| O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Secrétaire | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 55241590004 | ||||||||||
| PARSONS, Steven Ian | Secrétaire | 13 Moreton Road South Round Green LU2 0TL Luton Bedfordshire | British | 87152410003 | ||||||||||
| STRIDE, Andrew William | Secrétaire | 6 Tilbury Road East Haddon NN6 8BX Northampton | British | 62422770001 | ||||||||||
| BOWCOCK, Philip Hedley | Administrateur | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow Lanarkshire | England | British | 158744440001 | |||||||||
| BROWN, Gary | Administrateur | Holly Tree House CV23 8AT Flecknoe Warwicks | British | 94339190002 | ||||||||||
| BURFORD, Alistair Graham | Administrateur | The Jungle Madingley Road, Coton CB23 7PH Cambridge | England | British | 124289050002 | |||||||||
| BURNS, Andrew Rae | Administrateur | 11 Glebe Avenue EN2 8NZ Enfield Middlesex | England | British | 54722740002 | |||||||||
| COOK, John | Administrateur | 55 Linefield Road DD7 6DT Carnoustie Angus | Scotland | British | 1388150003 | |||||||||
| DACRE, Ronald Robert Hugh | Administrateur | 21 Keirsbeath Court Kingseat KY12 0UE Dunfermline Fife | British | 813060001 | ||||||||||
| GARVIE, David Campbell | Administrateur | Craighill 18 Murray Place PH1 1BP Perth Perthshire | British | 4668490001 | ||||||||||
| GUTTERIDGE, Timothy Roy | Administrateur | 38 Northumberland Street EH3 6JA Edinburgh Scotland | British | 6050070003 | ||||||||||
| HEPBURN, Gavin Andrew Harley | Administrateur | 22 Mansionhouse Road EH9 2JD Edinburgh Midlothian | British | 211700001 | ||||||||||
| HEPBURN, Gavin Andrew Harley | Administrateur | 22 Mansionhouse Road EH9 2JD Edinburgh Midlothian | British | 211700001 | ||||||||||
| JUDGE, Michael | Administrateur | 12 Alexander Street KY4 9AA Cowdenbeath Fife | British | 653260001 | ||||||||||
| LIVINGSTONE, Peter Wishart | Administrateur | 12 Normand Road Dysart KY1 2XJ Kirkcaldy Fife | British | 110527270001 | ||||||||||
| MACLEOD, Brian | Administrateur | 18 Scobie Place KY12 7RX Dunfermline Fife | British | 43111330001 | ||||||||||
| MALCOLM, Alexander Ramsay | Administrateur | 2 Talla Park KY13 8AB Kinross Fife | Scotland | British | 66254130001 | |||||||||
| MARKS, Andrew Geoffrey | Administrateur | 170 Long Meadow Bedgrove HP21 7EB Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | 98760390001 | |||||||||
| MILLS, Adam Francis | Administrateur | The Walton Canonry 69 The Close SP1 2EN Salisbury Wiltshire | British | 4058810004 | ||||||||||
| MORRIS, David Charles | Administrateur | 12 Victoria Street LU6 3BA Dunstable Bedfordshire | British | 98815770001 | ||||||||||
| O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard | Administrateur | 5 High Oaks Road AL8 7BJ Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 55241590004 | |||||||||
| PRENTICE, William | Administrateur | 88 Dunnikier Road KY2 5AW Kirkcaldy Fife | British | 653270001 | ||||||||||
| RITCHIE, Alastair James | Administrateur | Mickry Lodge 56 Gamekeepers Road EH4 6LS Edinburgh Lothian | British | 38770080002 | ||||||||||
| THOMAS, Stephen Charles | Administrateur | Newnham Hall Poets Way, Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 66198390004 | ||||||||||
| WILLITS, Henry Andrew | Administrateur | Stable Barn Hall Farm Charwelton Road NN11 3TA Preston Capes Northamptonshire | British | 90132600002 |
HANOVER FOUR LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Créé le 07 févr. 1995 Livré le 23 févr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 16 août 1982 Livré le 31 août 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by t s forster & sons LTD | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 19 mars 1982 Livré le 06 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due, or to become due by park naval engineering LTD | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 09 févr. 1981 Livré le 13 févr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by robt. Balbirnie & company LTD and/or another | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 13 mars 1979 Livré le 22 mars 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by fife forester LTD and/or others | |
Brèves mentions All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by bank of scotland in name of thomson brothers (kirkcaldy) LTD. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0