WALLETS MARTS PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWALLETS MARTS PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC018065
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WALLETS MARTS PLC ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe WALLETS MARTS PLC ?

    Adresse du siège social
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WALLETS MARTS PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WALLETS MARTS PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juin 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 juil. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 juin 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour WALLETS MARTS PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Inscription de la charge SC0180650001, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650002, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650003, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650004, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650005, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650006, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650007, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650008, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0180650009, créée le 15 janv. 2026

    6 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2025 avec mises à jour

    41 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 163 Bath Street Glasgow G2 4SQ Scotland à Fifth Floor, St Vincent Plaza 319 st Vincent Street Glasgow G2 5RZ le 26 mai 2025

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Helen Ruth Murdoch le 06 mars 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Kyle Graham le 06 mars 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Dalglish le 06 mars 2025

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    26 pagesAA

    Nomination de Mr Robert Ramsay Mckinnel en tant qu'administrateur le 21 août 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Telford Oxley en tant qu'administrateur le 21 août 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gillian Dykes en tant que directeur le 31 mars 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2024 avec mises à jour

    39 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    26 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2023 avec mises à jour

    39 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew Semple Kelly en tant que directeur le 04 juin 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Davidson Chalmers Stewart (Secretarial Services) Limited en tant que secrétaire le 01 janv. 2023

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Messrs. Hewats, (Solicitors) en tant que secrétaire le 01 janv. 2023

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de WALLETS MARTS PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIDSON CHALMERS STEWART (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    12
    Scotland
    Secrétaire
    Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    12
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC201105
    137092310002
    DALGLISH, Robert
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    Administrateur
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    ScotlandBritish81991430002
    GRAHAM, Robert Kyle
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    Administrateur
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    ScotlandBritish53645560001
    MCKINNEL, Robert Ramsay
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    Administrateur
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    ScotlandBritish216774060001
    MURDOCH, Helen Ruth
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    Administrateur
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    ScotlandBritish198509650001
    OXLEY, Richard Telford
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    Administrateur
    319 St Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Fifth Floor, St Vincent Plaza
    Scotland
    ScotlandBritish166041520001
    MESSRS GILLESPIE GIFFORD & BROWN WS
    133 King Street
    DG7 1NA Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Secrétaire
    133 King Street
    DG7 1NA Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    557910001
    MESSRS. HEWATS, (SOLICITORS)
    63 King Street
    Castle Douglas
    DG7 1AG Kirkcudbrightshire
    Dumfries & Galloway
    Scotland
    Secrétaire
    63 King Street
    Castle Douglas
    DG7 1AG Kirkcudbrightshire
    Dumfries & Galloway
    Scotland
    64238680001
    ANDERSON, Robert Beattie
    Thornwood
    104 Edinburgh Road
    DG1 1JU Dumfries
    Administrateur
    Thornwood
    104 Edinburgh Road
    DG1 1JU Dumfries
    ScotlandBritish44623070003
    ATKINSON, Thomas Losh
    Auchengyle
    Chapelknowe
    DG14 0XX Canonbie
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Auchengyle
    Chapelknowe
    DG14 0XX Canonbie
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish67471050001
    BIGGAR, James
    Chapelton
    Castle Douglas
    Administrateur
    Chapelton
    Castle Douglas
    British557920001
    BROOKE, Alexander Keith
    Carscreugh
    Glenluce
    DG8 0NU Newton Stewart
    Administrateur
    Carscreugh
    Glenluce
    DG8 0NU Newton Stewart
    ScotlandBritish40634170001
    CAMPBELL, William Alan
    Slagnaw
    Kelton
    DG7 1SY Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Slagnaw
    Kelton
    DG7 1SY Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    British11752680001
    DALRYMPLE, John
    Auchtralure
    DG9 8HU Stranraer
    Wigtownshire
    Administrateur
    Auchtralure
    DG9 8HU Stranraer
    Wigtownshire
    British11752660001
    DYKES, Gillian
    Moniaive
    Thornhill
    DG3 4EB Dumfries
    Old Crawfordton
    Dumfries & Galloway
    United Kingdom
    Administrateur
    Moniaive
    Thornhill
    DG3 4EB Dumfries
    Old Crawfordton
    Dumfries & Galloway
    United Kingdom
    United KingdomBritish204869690001
    FARRIES, Francis James
    Catlegower
    DG7 1NH Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Catlegower
    DG7 1NH Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    British11752700001
    FERGUSSON, Margaret Wilson
    Barlaes
    Dalry
    DG7 3TZ Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Barlaes
    Dalry
    DG7 3TZ Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    British11752690001
    GILLESPIE, Thomas Corrie
    Dunrod Lodge
    Borgue
    DG6 4TT Kirkcudbright
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Dunrod Lodge
    Borgue
    DG6 4TT Kirkcudbright
    Kirkcudbrightshire
    ScotlandBritish20505610002
    GOURLAY, John Francis Stewart
    Auchencheyne
    DG3 4EP Moniaive
    Dumfriesshire
    Administrateur
    Auchencheyne
    DG3 4EP Moniaive
    Dumfriesshire
    British159580001
    KELLY, Andrew Semple
    Kirkbean
    DG2 8AB Dumfries
    Airdrie Farm
    Dumfriesshire
    Scotland
    Administrateur
    Kirkbean
    DG2 8AB Dumfries
    Airdrie Farm
    Dumfriesshire
    Scotland
    ScotlandBritish23888030005
    KINGAN, James
    Lochhill
    New Abbey
    Dumfries
    Administrateur
    Lochhill
    New Abbey
    Dumfries
    British160360001
    LINDSAY, William Alexander
    Auchencairn
    DG7 1RE Castle Douglas
    Culnaightrie
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Auchencairn
    DG7 1RE Castle Douglas
    Culnaightrie
    Kirkcudbrightshire
    ScotlandBritish139446240001
    MCKINNEL, Robert James
    DG8 9LJ Newton Stewart
    Meikle Croft
    Wigtownshire
    Administrateur
    DG8 9LJ Newton Stewart
    Meikle Croft
    Wigtownshire
    ScotlandBritish56739820002
    MCQUEEN, James Richard
    Crofts
    DG7 3HX Castle Douglas
    Administrateur
    Crofts
    DG7 3HX Castle Douglas
    British557940001
    STUART, John Andrew Morrison
    Ernespie Farm
    DG7 3JG Castle Douglas
    Administrateur
    Ernespie Farm
    DG7 3JG Castle Douglas
    British557950001
    YOUNG, David Lyle
    St. Andrew Street
    DG7 1EN Castle Douglas
    Craigmore
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    St. Andrew Street
    DG7 1EN Castle Douglas
    Craigmore
    Kirkcudbrightshire
    British139446080001
    YOUNG, Francis Bruce
    Congeith
    Kirkgunzeon
    DG2 8JT Dumfries
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Congeith
    Kirkgunzeon
    DG2 8JT Dumfries
    Kirkcudbrightshire
    British494290001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WALLETS MARTS PLC ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    29 juin 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WALLETS MARTS PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction at A713/A75 (fell wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more dully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energyfarm UK Fell LLP
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (margree wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energyfarm UK Margree LLP
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction at A713/A74 (glenshimmeroch wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energyfarm UK Glenshimmeroch LLP
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (halfmark wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (garcrogo wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (manquhill wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (cornharrow wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (divot hill wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 janv. 2026
    Livré le 28 janv. 2026
    En cours
    Brève description
    Land adjacent to junction A713/A75 (collieston hill wind farm) being all and whole the subjects shown outlined in red on the plan annexed and signed as relative to the instrument which subjects form part and portion of all and whole the fields and enclosures extending to 18.696 acres, parts of the lands of springfield and the lands of sandfield parks and as more fully described in the instrument.
    Personnes ayant droit
    • Energiekontor UK LTD
    Transactions
    • 28 janv. 2026Enregistrement d'une charge (MR01)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0