CHARLES CARPENTER, LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHARLES CARPENTER, LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC018125
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHARLES CARPENTER, LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe CHARLES CARPENTER, LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHARLES CARPENTER, LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 févr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour CHARLES CARPENTER, LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Nomination de Mr Simon Terence Douglas en tant qu'administrateur le 14 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Philip Hedley Bowcock en tant que directeur le 14 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 août 2011

    État du capital au 15 août 2011

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Hedley Bowcock en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jayne Fearn en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 25 févr. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Marks en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Luminar Leisure Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2009

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 28 févr. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 01 mars 2007

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 02 mars 2006

    8 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CHARLES CARPENTER, LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158737690001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Administrateur
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03802937
    152179100001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Secrétaire
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    KAUFMAN, Alan
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    British3111940001
    MOIR, Margaret
    Tree Tops 106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Tree Tops 106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Lanarkshire
    British897310002
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secrétaire
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Administrateur
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Administrateur
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    KAUFMAN, Alan
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    British3111940001
    MACDONALD, Donald Hugh
    78 East Bankton Place
    EH54 9BZ Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    78 East Bankton Place
    EH54 9BZ Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British3111970001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Administrateur
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MCINTYRE, Robert
    5 Dickburn Crescent
    FK4 1DJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Administrateur
    5 Dickburn Crescent
    FK4 1DJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British897300001
    MCKENZIE, Douglas Charles
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    British48853570001
    MOIR, David
    Cairnoch
    Coach Road
    Kilsyth
    Administrateur
    Cairnoch
    Coach Road
    Kilsyth
    British29080002
    MOIR, John
    106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Administrateur
    106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    British36871270001
    MONK, John
    160 Fox Lane
    Leyland
    PR5 1HE Preston
    Lancashire
    England
    Administrateur
    160 Fox Lane
    Leyland
    PR5 1HE Preston
    Lancashire
    England
    British3111930001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    ROBERTSON, John
    15 Avondale Place
    East Kilbride
    G74 1NU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    15 Avondale Place
    East Kilbride
    G74 1NU Glasgow
    Lanarkshire
    British1373520001
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Administrateur
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    HANOVER THREE LIMITED
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    62089160004

    CHARLES CARPENTER, LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 08 févr. 1995
    Livré le 23 févr. 1995
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 19 janv. 1990
    Livré le 07 févr. 1990
    En cours
    Montant garanti
    £72,120
    Brèves mentions
    Factory 15-23 telford rd lenziemill cumbernauld dmb 12979.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cumbernauld Development Corporation
    Transactions
    • 07 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 16 mai 1985
    Livré le 22 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Factory premises with yard 15/23 telford rd cumbernauld.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 22 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 26 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 03 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond of cash credit and by the company floating charge
    Créé le 03 mai 1963
    Livré le 22 mai 1963
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale & North of Scotland Bank LTD
    Transactions
    • 22 mai 1963Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0