ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéARTHUR DUTHIE & CO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC020131
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    • (5138) /

    Où se situe ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    48 Castle Street
    Edinburgh
    EH2 3LX Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ARTHUR DUTHIE & COMPANY, LIMITED04 janv. 193804 janv. 1938

    Quels sont les derniers comptes de ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2000

    Quels sont les derniers dépôts pour ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    2 pages4.17(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    20 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    legacy

    4 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDERSON STRATHERN WS
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    48 Castle Street
    EH2 3LX Edinburgh
    Midlothian
    33516610001
    SHAYER, John
    86 Duncan Drive
    IV30 4NH Elgin
    Moray
    Administrateur
    86 Duncan Drive
    IV30 4NH Elgin
    Moray
    British8720001
    YOUNG, Robert Brian
    Clarinish
    G84 8NH Rhu
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Clarinish
    G84 8NH Rhu
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish8160001
    YOUNG, Thomas Evan Robb
    Blucairn Stotfield Road
    IV31 6QT Lossiemouth
    Morayshire
    Administrateur
    Blucairn Stotfield Road
    IV31 6QT Lossiemouth
    Morayshire
    British8150001
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    SCOTT, John Sutherland
    Port Beag 125 Pluscarden Road
    IV30 1SU Elgin
    Morayshire
    Administrateur
    Port Beag 125 Pluscarden Road
    IV30 1SU Elgin
    Morayshire
    ScotlandBritish8710001

    ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 19 déc. 1989
    Livré le 04 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 janv. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 26 oct. 1989
    Livré le 09 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by george james garden and others
    Brèves mentions
    16 shares in fishing boat "auriga ii" inverness rss no A11781.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 24 oct. 1989
    Livré le 06 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due on an account current in the name of william bruce more and another
    Brèves mentions
    16 shares in fishing boat "hazelmore ii" buckie rss A10574.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 08 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shipping mortgage
    Créé le 29 sept. 1988
    Livré le 14 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    1 share in fishing boat "argyll" of inverness ins 217.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 29 sept. 1988
    Livré le 14 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    5 shares in fishing boat "argyll" of inverness ins 217.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shipping mortgage
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 26 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    7 shares in fishing boat "courageous" of inverness INS146.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 22 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    7 shares in "oceanic" of inverness INS100.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 14 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 16 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    6 shares in "karen anne" of inverness ins 61.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of variation
    Créé le 06 nov. 1986
    Livré le 12 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    D & r 900,000 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    3/16 shares "emma thomson ii".
    Personnes ayant droit
    • Aktieselskabet Danks Skibsfinansiering
    Transactions
    • 12 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 22 oct. 1986
    Livré le 30 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £521,675 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    See page 2 doc 157 "jaseline".
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 22 oct. 1986
    Livré le 30 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £521,675 and all other sums due or to become due
    Brèves mentions
    See page 2 doc 156 m/b "victory".
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Statutory mortgage
    Créé le 22 oct. 1986
    Livré le 28 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16/16TH shares of and in m/b "jaseline" regd inverness ins 248.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Statutory mortgage
    Créé le 22 oct. 1986
    Livré le 28 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16/16TH shares of and in m/b "victory" regd inverness ins 252.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee
    Créé le 16 janv. 1986
    Livré le 21 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Sea Fish Industry Authority
    Transactions
    • 21 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee
    Créé le 07 févr. 1985
    Livré le 14 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by maclae duggie to mcpherson LTD
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Sea Fish Industry Authority
    Transactions
    • 14 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 14 nov. 1984
    Livré le 26 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £406,059 and all further sums due or to become due by the company and another
    Brèves mentions
    The "mortgaged premises" being the ship mv karen anne.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Statutory mortgage
    Créé le 14 nov. 1984
    Livré le 26 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company & another
    Brèves mentions
    8/16 shares mv "karen anne".
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee
    Créé le 12 nov. 1984
    Livré le 16 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Sea Fish Industry Authority
    Transactions
    • 16 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Agreement
    Créé le 07 nov. 1984
    Livré le 23 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Any moneys which may be payable to the company in terms of clause 9A of the deed of covenant.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Trade & Industry
    Transactions
    • 23 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Pledge agreement
    Créé le 24 sept. 1984
    Livré le 05 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The sums of £81,211.80, £224,847.20 and all interest due.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shipowners agreement
    Créé le 21 sept. 1984
    Livré le 05 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All moneys which may be payable to the company in accordance with the terms of the deed of covenant.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Shipping mortgage
    Créé le 21 mars 1984
    Livré le 03 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    4/16THS of M.V. "hazlemore ii" registered at the port of buckie under official no 83.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of covenant
    Créé le 20 mars 1984
    Livré le 03 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by the company & others
    Brèves mentions
    M.V. "hazlemore ii" the earnings, insurances and the requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 23 déc. 1983
    Livré le 12 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due by the company and others
    Brèves mentions
    4/16THS hazelmore ii the earnings of the ship requisition compensation.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee
    Créé le 14 nov. 1983
    Livré le 16 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due from macrae duggie mcpherson the charges
    Brèves mentions
    The whole of the property.
    Personnes ayant droit
    • Sea Fish Industry Authority
    Transactions
    • 16 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    ARTHUR DUTHIE & CO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 juin 2011Dissolved on
    31 oct. 2001Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kenneth A Ross
    375 West George Street
    Glasgow
    G2 4LH
    practitioner
    375 West George Street
    Glasgow
    G2 4LH
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0