THE TWEEDDALE PRESS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE TWEEDDALE PRESS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC020984
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    • Édition de journaux (58130) / Information et communication

    Où se situe THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Passage de l'administration à la dissolution

    33 pagesAM23(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    33 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    5 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10(Scot)

    Cessation de la nomination de Michael Guy Butterworth en tant que directeur le 17 mai 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Michael Mccall en tant que secrétaire le 17 mai 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David John King en tant que directeur le 17 mai 2019

    1 pagesTM01

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 8th Floor Orchard Brae House, 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS à 272 Bath Street Glasgow G2 4JR le 06 déc. 2018

    2 pagesAD01

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    4 pages2.15B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    111 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    2 pages2.11B(Scot)

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2017

    23 pagesAA

    Nomination de Mr Michael Guy Butterworth en tant qu'administrateur le 24 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ashley Gilroy Mark Highfield en tant que directeur le 05 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS Scotland à 8th Floor Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 avr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS

    1 pagesAD03

    Comptes annuels établis au 02 janv. 2016

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2016

    État du capital au 11 avr. 2016

    • Capital: GBP 96,525
    SH01

    Cessation de la nomination de Alan Stephen Plews en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan Stephen Plews en tant qu'administrateur le 01 août 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUDGEON, Edward
    25 Cottage Road
    NE71 6AD Wooler
    Northumberland
    Secrétaire
    25 Cottage Road
    NE71 6AD Wooler
    Northumberland
    British19728160001
    MCCALL, Peter Michael
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Secrétaire
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    161445620001
    SIMMONS, John Edward
    4 Valley View
    Tweedmouth
    TD15 2ED Berwick Upon Tweed
    Secrétaire
    4 Valley View
    Tweedmouth
    TD15 2ED Berwick Upon Tweed
    British37365190002
    SMAIL, John Daniel Richardson
    Lindean Farmhouse
    Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    Borders
    Secrétaire
    Lindean Farmhouse
    Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    Borders
    British41960002
    SPEIGHT, Arthur John Peter
    37 High Street
    NE71 6BU Wooler
    Northumberland
    Secrétaire
    37 High Street
    NE71 6BU Wooler
    Northumberland
    British41920001
    ANDREW, James Houston
    Fogo Mains Fogo
    TD11 3RA Duns
    Berwickshire
    Administrateur
    Fogo Mains Fogo
    TD11 3RA Duns
    Berwickshire
    United KingdomBritish62235680001
    ARMSTRONG, Anthony Bowes
    Riverview Cottage
    Lilliesleaf
    TD6 9JB Melrose
    Roxburghshire
    Administrateur
    Riverview Cottage
    Lilliesleaf
    TD6 9JB Melrose
    Roxburghshire
    British35246880001
    BIRKETT, Stuart James
    10 Eildon View
    TD15 2FQ Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Administrateur
    10 Eildon View
    TD15 2FQ Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    United KingdomBritish174124340001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Administrateur
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    BROTHERSTON, Richard
    8 Strathearn Road
    EH9 2AE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Strathearn Road
    EH9 2AE Edinburgh
    Midlothian
    British39940001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    EnglandBritish76600500002
    CASKIE, David Baird
    88 Maggiewoods Loan
    FK1 5EH Falkirk
    Administrateur
    88 Maggiewoods Loan
    FK1 5EH Falkirk
    ScotlandBritish45898950001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Administrateur
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    DOWNIE, George Waddell
    The Gables,Close Farm
    Hatch Beauchamp
    TA3 6AE Taunton
    Somerset
    Administrateur
    The Gables,Close Farm
    Hatch Beauchamp
    TA3 6AE Taunton
    Somerset
    British26306280002
    DUDGEON, Edward
    25 Cottage Road
    NE71 6AD Wooler
    Northumberland
    Administrateur
    25 Cottage Road
    NE71 6AD Wooler
    Northumberland
    British19728160001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Administrateur
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    KING, David John
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    United KingdomBritish179020430001
    MCINTYRE, Keith William
    49 Meldrum Mains
    Glenmavis
    ML6 0QQ Airdrie
    Lanarkshire
    Administrateur
    49 Meldrum Mains
    Glenmavis
    ML6 0QQ Airdrie
    Lanarkshire
    ScotlandBritish112687860001
    MCPHERSON, Stuart
    8 Heriot Road
    Lenzie
    G66 5AY Glasgow
    Administrateur
    8 Heriot Road
    Lenzie
    G66 5AY Glasgow
    ScotlandBritish986760004
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Administrateur
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    PLEWS, Alan Stephen
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Administrateur
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    EnglandBritish27819010002
    RICHARDSON, John Daniel
    Lindean Farmhouse Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    Administrateur
    Lindean Farmhouse Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    British47707970001
    SMAIL, Derek James Richardson
    Waimate
    East Ord
    TD15 2NS Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Administrateur
    Waimate
    East Ord
    TD15 2NS Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    EnglandBritish41950001
    SMAIL, Dorothy Margaret
    Kiwi Cottage
    Scremerston
    TD15 2RB Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Administrateur
    Kiwi Cottage
    Scremerston
    TD15 2RB Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    British41940001
    SMAIL, James Ingram Miles
    Kiwi Cottage
    Scremerston
    TD15 2RB Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    Administrateur
    Kiwi Cottage
    Scremerston
    TD15 2RB Berwick Upon Tweed
    Northumberland
    British41930001
    SMAIL, John Daniel Richardson
    Lindean Farmhouse
    Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    Borders
    Administrateur
    Lindean Farmhouse
    Lindean
    TD7 4QW Selkirk
    Borders
    British41960002
    WALLACE, David Forster
    The Whins
    Unthbank Square
    TD15 2NG Berwick-Upon-Tweed
    Northumberland
    Administrateur
    The Whins
    Unthbank Square
    TD15 2NG Berwick-Upon-Tweed
    Northumberland
    British65583180002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE TWEEDDALE PRESS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Johnston Publishing Limited
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    06 avr. 2016
    Bourges Boulevard
    PE1 1NG Peterborough
    Unex House - Suite B
    Cambridgeshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement01919088
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    THE TWEEDDALE PRESS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2014
    Livré le 04 juil. 2014
    En cours
    Brève description
    All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 04 juil. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 juil. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 16 juin 2014
    Livré le 24 juin 2014
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch for Itself and as Security Agent
    Transactions
    • 24 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 juil. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Deed of accession
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 06 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 04 mars 1991
    Livré le 11 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The hermitage selkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 12 sept. 1986
    Livré le 24 sept. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £27375 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    13 thomson gate tweedmonte.
    Personnes ayant droit
    • Northern Rock Building Society
    Transactions
    • 24 sept. 1986Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 août 1979
    Livré le 30 août 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop and dwellinghouse forming numbers 1 & 3 easter street, dums in the town and parish of dums in the county of berwick.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 août 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 15 août 1979
    Livré le 21 août 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects in boarding school yard, berwick upon tweed.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1979Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 15 août 1979
    Livré le 21 août 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    94/94A marygate, berwick upon tweed.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1979Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 15 août 1979
    Livré le 21 août 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Kuri cottages, scremerston, berwick upon tweed.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 août 1979Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mai 1979
    Livré le 25 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    51 high street selkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mai 1979
    Livré le 25 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    53 high street, selkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mai 1979
    Livré le 25 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    19 bridge street, kelso, roxburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mai 1979
    Livré le 25 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Northmost shop at 33 high street, jedburgh. County of roxburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 janv. 1979
    Livré le 02 févr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 févr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 déc. 1976
    Livré le 07 déc. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property "weimate", east old berwick upon tweed.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1976Enregistrement d'une charge
    • 21 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    G r s roxburgh standard security
    Créé le 05 mars 1976
    Livré le 08 mars 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land & store at 8 buccleuch st., Hawick.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mars 1976Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    THE TWEEDDALE PRESS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 avr. 2020Administration ended
    17 nov. 2018Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0