HFL REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHFL REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC021928
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HFL REALISATIONS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOUSE OF FRASER LIMITED08 nov. 200608 nov. 2006
    HOUSE OF FRASER PLC11 déc. 194111 déc. 1941

    Quels sont les derniers comptes de HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 janv. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10(Scot)
    YBXJQPKA

    Fin automatique de l'administration

    15 pagesAM20(Scot)
    YBXEDKFM

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pagesAM10(Scot)
    YBXEDJWG

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pagesAM10(Scot)
    YBCG8KHL

    Démission d'un administrateur

    3 pagesAM15(Scot)
    YB76GQ00

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10(Scot)
    YB0DZET7

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10(Scot)
    YAD5EXMW

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10(Scot)
    SA10WQ8W

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10(Scot)
    Y9DVP6K3

    Avis de prolongation de la période d'administration

    5 pagesAM19(Scot)
    S9BP0UY1

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10(Scot)
    S8EUX1HT

    Avis de prolongation de la période d'administration

    5 pagesAM19(Scot)
    S8BXUVST

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    15 pages2.20B(Scot)
    S80W7UA2

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)/2.14B(Scot)

    18 pages2.15B(Scot)
    S7G7IAAI

    Avis de la réalisation de l'accord amiable

    8 pages1.4(Scot)
    A7DCUZPM

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)
    S7DKFQ2G

    Certificat de changement de nom

    Company name changed house of fraser LIMITED\certificate issued on 29/08/18
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name29 août 2018

    Avis de changement de nom"

    CONNOT
    S7CXXN5F

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de Granite House 31 Stockwell Street Glasgow G1 4RZ à C/O Ernst & Young Llp, Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 22 août 2018

    2 pagesAD01
    A7CPXN1N

    Proposition de l'administrateur

    160 pages2.16B(Scot)
    S7CSXLZU

    Nomination d'un administrateur

    2 pages2.11B(Scot)
    S7CLEQRC

    Nomination de Mr Yong Shen en tant qu'administrateur le 30 juil. 2018

    2 pagesAP01
    X7C143JE

    Qui sont les dirigeants de HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEARSEY, Peter Geoffrey
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    Secrétaire
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    BritishSolicitor100685710010
    CHENG, Fei-Er
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    ChinaChineseCompany Director245301610001
    HEARSEY, Peter Geoffrey
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    EnglandBritishExecutive Director230483470001
    SHEN, Yong
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director248888140001
    WILLIAMSON, Alexander Patrick
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    C/O Ernst & Young Llp, Atria One
    Scotland
    EnglandBritishCeo251809220001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    British55757700003
    DAVIES, James Ralph Parnell
    24 Batchelors Way
    HP7 9AJ Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    24 Batchelors Way
    HP7 9AJ Amersham
    Buckinghamshire
    British47335710002
    JERMAN, Susan
    29 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Secrétaire
    29 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    British253160001
    SIDDELL, Anne Claire
    10 Hearn Close
    Manor Road
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    10 Hearn Close
    Manor Road
    HP10 8JT Penn
    Buckinghamshire
    British9945720001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishFinance Director55757700003
    AL FAYED, Mohamed
    60 Park Lane
    W1K 1QE London
    Administrateur
    60 Park Lane
    W1K 1QE London
    EnglandEgyptianDirector Of Companies2182650001
    BLISS, Michael
    17 Dearne Close
    HA7 3AT Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    17 Dearne Close
    HA7 3AT Stanmore
    Middlesex
    BritishRetail Executive250020001
    BOLLICIER, Peter
    1 Walton Place
    SW3 1RH London
    Administrateur
    1 Walton Place
    SW3 1RH London
    SwissRetail Exec38221750001
    CASSAR, Stefan John
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    EnglandBritishNone117062050006
    CASSAR, Stefan John
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    Administrateur
    22 Hazelwell Road
    SW15 6HL London
    EnglandBritishCompany Director117062050001
    COLEMAN, John
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Administrateur
    Lodge House Lodge House Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritishCompany Director56366250008
    COULL, Ian David
    3, The Woodlands
    Penn
    HP10 8JD High Wycombe
    Sleepy Hollow
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    3, The Woodlands
    Penn
    HP10 8JD High Wycombe
    Sleepy Hollow
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector140437190001
    CRADDOCK, William Aleck
    17 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    Administrateur
    17 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    BritishRetail Executive254020001
    CRAIG, Ronald Findlay
    Lansdowne
    Butlers Dne Road
    CR3 7HH Woldingham
    Surrey
    Administrateur
    Lansdowne
    Butlers Dne Road
    CR3 7HH Woldingham
    Surrey
    BritishRetail Executive17895500001
    ELLIOT, Colin David
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    Administrateur
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    United KingdomBritishChief Financial Officer178756480001
    FAYED, Ali
    60 Park Lane
    W1K 1QE London
    Administrateur
    60 Park Lane
    W1K 1QE London
    EnglandBritishCompany Director2182670001
    FRITH, Stanley William
    Thornfield House 13 Vine Road
    Barnes
    SW13 0NE London
    Administrateur
    Thornfield House 13 Vine Road
    Barnes
    SW13 0NE London
    BritishPersonnel Director70003870001
    GIFFORD, Mark Anthony
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    United Kingdom
    Administrateur
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director87902570005
    GORDON DUGDALE, Ann
    7 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    Administrateur
    7 Elthiron Road
    SW6 4BN London
    BritishTrading Director49736030002
    HAMPSON, Robert John
    5 Trevor Square
    SW7 1DT London
    Administrateur
    5 Trevor Square
    SW7 1DT London
    AustralianRetail Executive250150001
    HANCOCK, Tony Charles
    2 The Laurels
    29a Sidney Road
    KT12 2NA Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    2 The Laurels
    29a Sidney Road
    KT12 2NA Walton On Thames
    Surrey
    BritishRetail Executive103883780001
    HERBERT, Jeffrey William
    Baytrees
    Long Road West Dedham
    CO7 6EL Colchester
    Essex
    Administrateur
    Baytrees
    Long Road West Dedham
    CO7 6EL Colchester
    Essex
    EnglandBritishCompany Director28246390001
    HIBBERT, Stephen
    Manor House
    Dockenfield
    GU10 4HL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Manor House
    Dockenfield
    GU10 4HL Farnham
    Surrey
    BritishOperations Director37097410001
    HOGBEN, Norman Muirhead
    Willow Hayne 46 Chantry View Road
    GU1 3XT Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Willow Hayne 46 Chantry View Road
    GU1 3XT Guildford
    Surrey
    BritishChartered Surveyor254030001
    JENNINGS, Andrew Richard
    45 Kensington Square
    W8 5HP London
    Administrateur
    45 Kensington Square
    W8 5HP London
    BritishReatil Executive35311850001
    JENNINGS, Andrew Richard
    45 Kensington Square
    W8 5HP London
    Administrateur
    45 Kensington Square
    W8 5HP London
    BritishRetail Executive35311850001
    JOHANNESSON, Jon Asgeir
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    Administrateur
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    IcelandIcelandicCompany Director78382920001
    JONES, Graham Wallace
    56 Millbank
    SW1P 4RL London
    Administrateur
    56 Millbank
    SW1P 4RL London
    AustralianDirector250050001
    KING, John
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    United Kingdom
    Administrateur
    31 Stockwell Street
    G1 4RZ Glasgow
    Granite House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119328820005
    LIVESEY, Paul Bryan
    Mares Hill Hedgerley Lane
    SL9 7NS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mares Hill Hedgerley Lane
    SL9 7NS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director253440002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HFL REALISATIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Yafei Yuan
    Software Avenue
    Yuhuatai District
    Nanjing
    68
    Jiangsu Province
    China
    06 avr. 2016
    Software Avenue
    Yuhuatai District
    Nanjing
    68
    Jiangsu Province
    China
    Non
    Nationalité: Chinese
    Pays de résidence: China
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    House Of Fraser (Uk & Ireland) Acquisitions Ltd
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    England
    06 avr. 2016
    Baker Street
    W1U 8AH London
    27
    England
    Non
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement5797766
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Hsbc Corporate Trustee Company (Uk) Ltd
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    England
    06 avr. 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    England
    Non
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement6447555
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HFL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 juil. 2018
    Livré le 27 juil. 2018
    En cours
    Brève description
    Leasehold property, including but not limited to, on 60A-64 north street and 105/113 high st, guildford (title number SY691021) and on 140/142 briggate, leeds (title number WYK653573). For more details, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 27 juil. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 juil. 2018
    Livré le 27 juil. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 27 juil. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 mars 2016
    Livré le 23 mars 2016
    En cours
    Brève description
    The mortgaged property being 26-40 (even) english street carlisle (title number CU148016) and other mortgaged property specified in the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for Each of the Secured Parties.
    Transactions
    • 23 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 août 2015
    Livré le 17 août 2015
    En cours
    Brève description
    First legal mortgage over all property now belonging to or vested in the chargor and all corresponding related rights. See form for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transactions
    • 17 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 août 2015
    Livré le 12 août 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 12 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 août 2015
    Livré le 12 août 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transactions
    • 12 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Floating charge
    Créé le 31 mai 2011
    Livré le 17 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 31 mai 2011
    Livré le 17 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 janv. 2009
    Livré le 22 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Global Consumer Finance Limited
    Transactions
    • 22 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 27 janv. 1994
    Livré le 01 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    108, 116, 120 argyle street, glasgow and 10/16(e) buchanan street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Trustee
    Transactions
    • 01 févr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 1993
    Livré le 25 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All actual, contingent, present and/or future obligations and liablilities (whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, cautioner, surety or otherwise)
    Brèves mentions
    108, 116, 188 and 120 argyle street and 10/16(e) buchanan street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Trustee
    Transactions
    • 25 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 mai 1993
    Livré le 13 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    169/185 argyle street, glasgow (tenants' interest), 106 don street, aberdeen, 194 rose street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Samul Montagu & Co Limited as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 13 mai 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed of pledge
    Créé le 30 avr. 1993
    Livré le 12 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgor pledges, charges and assigns to the trustee the shares and all dividends paid or payable after the date of the execution of the pledge on all or any of the shares and all stocks, shares, securities, rights, moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, preference, option rights, warrant rights or otherwise to or in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Trustee for and on on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 mai 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 30 avr. 1993
    Livré le 13 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See page 2 of doc paper apart.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montagu & Co Limited as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 13 mai 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 avr. 1993
    Livré le 12 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montague & Co Limited as Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 mai 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Transfer of property
    Créé le 21 avr. 1988
    Livré le 10 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63-97 kensington high st., London.
    Personnes ayant droit
    • House of Fraser Property Investment PLC
    Transactions
    • 10 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Transfer of property
    Créé le 21 avr. 1988
    Livré le 10 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    63-67 kensington high st., London.
    Personnes ayant droit
    • Samuel Montague & Co. LTD
    Transactions
    • 10 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 12 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    HFL REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 juin 2018Date of meeting to approve CVA
    10 août 2018Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    10 août 2018Administration started
    10 févr. 2023Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Craig Anthony Lewis
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Ernst & Young Llp 1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    practitioner
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0