PORTREE SALMON FARMERS LIMITED

PORTREE SALMON FARMERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPORTREE SALMON FARMERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC023085
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE WEST HIGHLAND SALMON FISHERIES COMPANY LTD.08 janv. 194508 janv. 1945

    Quels sont les derniers comptes de PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 26 oct. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Requisite entries in statutory records approved 07/10/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Craig Anderson en tant que directeur le 23 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Jóhan Regin Jacobsen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Odd Eliasen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7JA le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Morisons Llp 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8AN à Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL le 30 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Morisons Secretaries Limited en tant que secrétaire le 30 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2016

    État du capital au 11 janv. 2016

    • Capital: GBP 2,500
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Susan Margaret
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish98112250001
    ELIASEN, Odd
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284660001
    JACOBSEN, Jóhan Regin
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284920001
    AUCKLAND, Robert Ian
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    British110880950001
    CROSSAN, Finlay George
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    Secrétaire
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    British35503670001
    HISLOP, Mitchell
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British88287460001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Secrétaire
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    British82618570002
    MATHESON, Donald Duncan
    Berneray
    Staffin Road
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    Secrétaire
    Berneray
    Staffin Road
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    British57192550001
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Secrétaire
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    British84079420001
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Secrétaire
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    33516610002
    MORISONS SECRETARIES LIMITED
    c/o Morisons Llp
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1 Exchange Crescent
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Morisons Llp
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1 Exchange Crescent
    Scotland
    83549280002
    ANDERSON, Craig
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish179195860001
    AUCKLAND, Robert Ian
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritish110880950001
    ERSKINE, Alistair Morgan
    Garvault Lodge
    Advie
    PH26 3LP Grantown On Spey
    Morayshire
    Administrateur
    Garvault Lodge
    Advie
    PH26 3LP Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritish50316250001
    GARRETT, Edwin Charles
    The Beeches
    Banchory Devenick
    AB12 5YD Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    The Beeches
    Banchory Devenick
    AB12 5YD Aberdeen
    Aberdeenshire
    British38811750002
    HISLOP, Mitchell
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British88287460001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Administrateur
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    ScotlandBritish82618570002
    MARSHALL, Ian Paul
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish150818380001
    MASSON, John George
    499 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    499 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Great BritainBritish657210001
    MATHESON, Donald Duncan
    Berneray
    Staffin Road
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Berneray
    Staffin Road
    IV51 9HP Portree
    Isle Of Skye
    British57192550001
    MATHESON, Malcolm Kenneth
    Berneray
    Portree
    Isle Of Skye
    Administrateur
    Berneray
    Portree
    Isle Of Skye
    British947130001
    MULLINS, James Joseph
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    United KingdomIrish,129001130001
    ODDSEN, Oddgeir
    101 Sinclair Street
    G84 9HX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    101 Sinclair Street
    G84 9HX Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomNorwegian101119150002
    WHITE, Clare Anne
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish68763280001
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Administrateur
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    ScotlandBritish84079420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PORTREE SALMON FARMERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    06 avr. 2016
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Acts (Various)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc055225
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PORTREE SALMON FARMERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 27 août 1990
    Livré le 10 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Salmon fishings from portree to south bank of river leale.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 août 1990
    Livré le 28 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge floating charge
    Créé le 28 déc. 1987
    Livré le 08 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highlands and Islands Development Board
    Transactions
    • 08 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 31 oct. 1980
    Livré le 10 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground one thousandth part of acre lying to the south of the public road leading to the pier at uig, snizort, island of skye.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 nov. 1980Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0