SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | SC024591 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS ?
| Adresse du siège social | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 0245910005 | 23 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 sans liste des membres | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Margaret Mcleod en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alison Elliot en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Shulah Allan en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gordon Macrae en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Michelle Elizabeth Mccrindle en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Carole Scott Patrick le 21 nov. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2013 | 34 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Jackson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Professor Stephen Peter Osborne en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 sans liste des membres | 10 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Bannon en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Eliot James Stark en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Margaret Mcleod en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Susan Archibald en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Legge en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Diana Hekerem en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alexander Cole-Hamilton en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patricia Aniello en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2012 | 39 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 sans liste des membres | 10 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Hamer en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIME, Martin Paton | Secrétaire | 2a East Castle Road EH10 5AR Edinburgh | British | 25184190002 | ||||||
| ALLAN, Shulah | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 1078080002 | |||||
| ARCHIBALD, Susan | Administrateur | Keltyhill Avenue Keltyhill Avenue KY4 0LH Kelty 1 Fife Scotland | Scotland | Scottish | 125717660001 | |||||
| BANNON, Paul | Administrateur | Paties Road EH14 1EF Edinburgh 20 Scotland | Scotland | British | 174295520001 | |||||
| HAMER, Richard | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 134000640001 | |||||
| MACKAY, Neville | Administrateur | The Woll TD7 4NY Ashkirk Woodlands Selkirkshire | United Kingdom | British | 137033040001 | |||||
| MACRAE, Gordon | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 183505190001 | |||||
| MCCRINDLE, Michelle Elizabeth | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 181963450001 | |||||
| OSBORNE, Stephen Peter, Professor | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 176105160001 | |||||
| PATRICK, Carole Scott | Administrateur | Mansfield Traquair Centre 15 Mansfield Place EH3 6BB Edinburgh | Scotland | British | 120509960002 | |||||
| STARK, Eliot James | Administrateur | Paisley Gardens EH8 7JN Edinburgh 31 Scotland | United Kingdom | British | 116672260001 | |||||
| CONNOLLY, Rona | Secrétaire | 25 Roseneath Place EH9 1JD Edinburgh | British | 57072560001 | ||||||
| FLOCKHART, D Ross | Secrétaire | Longwood Humbie East Lothian | British | 896740001 | ||||||
| ANIELLO, Patricia Anne | Administrateur | 14 Mansfield Court Livingston Village EH54 7BJ Livingston West Lothian | Scotland | British | 118488920001 | |||||
| BEATTIE, Robert Barrowman | Administrateur | 51 Braehead Road Barnton EH4 6BD Edinburgh | British | 12816190001 | ||||||
| BEATTIE, Robert Barrowman | Administrateur | 51 Braehead Road Barnton EH4 6BD Edinburgh | British | 12816190001 | ||||||
| BLACK, Bruce | Administrateur | Csla - Roseberry House EH11 2XZ Edinburgh | British | 896980001 | ||||||
| BRODIE, Penny Anne | Administrateur | Woodside Oakbank Road PH10 6TB Blairgowrie Perthshire | Scotland | British | 85573840001 | |||||
| BRYERS, Philip | Administrateur | 8 Myrtle Park G42 8UQ Glasgow Lanarkshire | British | 19249320001 | ||||||
| BURNS, Elizabeth Kerr | Administrateur | 97b High Street FK13 6DL Tillicoultry Clackmannanshire | British | 41673730003 | ||||||
| BURNS, Elizabeth K | Administrateur | 2 Stalker Avenue FK13 6EY Tillicoultry Clackmannanshire | British | 41673730001 | ||||||
| CAIRNS, Michael Francis | Administrateur | 5 Low Brae EH48 4LU Torphichen West Lothian | British | 88733110001 | ||||||
| CALDWELL, Katherine | Administrateur | 44 Queen Square G41 2AZ Glasgow | British | 37416830001 | ||||||
| CAMPBELL, Hector Donald | Administrateur | 9 Linn Place Auldgirth DG2 0XH Dumfries Dumfriesshire | British | 804070001 | ||||||
| CARLIN, Louise Elizabeth Anne | Administrateur | 8 Blantyre Terrace Merchiston EH10 5AE Edinburgh | British | 45980380002 | ||||||
| CAVANAGH, Brian | Administrateur | 56 Broomhall Crescent EH12 7PF Edinburgh Midlothian | British | 54542840001 | ||||||
| CLARK, Anne Elizabeth | Administrateur | Achnamara Main Street PA48 7TL Port Charlotte Isle Of Islay | Scotland | British | 57979550001 | |||||
| CLARK, Pamela Ann Dean | Administrateur | College Of Roseisle IV30 Elgin Moray | British | 41504340001 | ||||||
| COHEN, Bronwen Jean, Dr | Administrateur | 11 Hermitage Drive EH10 6BX Edinburgh Midlothian | British | 30651640001 | ||||||
| COLE-HAMILTON, Alexander Geoffrey | Administrateur | 8/5 Portland Gardens EH6 6NJ Edinburgh Lothian | Scotland | British Canadian | 126641910001 | |||||
| COLLIS, Julia | Administrateur | 1 Glenwood Avenue ML6 8RY Airdrie Lanarkshire | British | 37123820001 | ||||||
| CONNOLLY, Rona | Administrateur | 25 Roseneath Place EH9 1JD Edinburgh | British | 57072560001 | ||||||
| COOKE, Nicholas Huxley | Administrateur | Easter Stonefield Port Of Menteith FK8 3RD Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 46220001 | |||||
| COPLAND, John Little | Administrateur | Rostherne House 35 Doune Road FK15 9HR Dunblane Perthshire | British | 896940001 | ||||||
| CURRAN, Ron | Administrateur | Newbattle Abbey Crescent EH22 3LP Dalkeith 90 Midlothian | British | 896930001 |
SCOTTISH COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 29 avr. 2014 Livré le 01 mai 2014 | En cours | ||
Brève description 2ND, 3RD and 4TH floors at hayweight house 23 lauriston street edinburgh MID150686. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 27 août 2009 Livré le 31 août 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 51 wilson street, glasgow GLA165563. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 27 août 2009 Livré le 31 août 2009 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fairways house, fairways business park, inverness INV11218. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 15 juin 1993 Livré le 24 juin 1993 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 18/19 claremont crescent, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 19 oct. 1992 Livré le 29 oct. 1992 | En cours | Montant garanti £232,500 | |
Brèves mentions 18/19 claremont crescent, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0