GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED

GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC025083
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BETT (DP) LIMITED07 sept. 199907 sept. 1999
    DICK PRECAST LIMITED16 juin 198816 juin 1988
    CHARLES DICK & SON, LIMITED25 févr. 194725 févr. 1947

    Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    État du capital au 12 janv. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809200001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Administrateur
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Administrateur
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    BETT, Stewart
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    Administrateur
    4 Pitempton Road
    Downfield
    DD3 9EJ Dundee
    Angus
    British175330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Administrateur
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    ELLIS, Gordon William
    77 Carlogie Road
    DD7 6EX Carnoustie
    Angus
    Administrateur
    77 Carlogie Road
    DD7 6EX Carnoustie
    Angus
    British319190001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Administrateur
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Administrateur
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001
    SAUNDERS, Gordon Scott
    4 Kippford Street
    Monifieth
    DD5 4TT Dundee
    Administrateur
    4 Kippford Street
    Monifieth
    DD5 4TT Dundee
    British39891340001
    TOWNSEND, Ian Trye
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    Administrateur
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    United KingdomBritish320150001

    GLADEDALE (ABERDEEN) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Letter of offset
    Créé le 10 avr. 1984
    Livré le 24 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by bett brothers & or others to the chargee
    Brèves mentions
    The balance at credit of any accounts held by bank of scotland in name of charles dick & son LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Letter of offset
    Créé le 13 oct. 1980
    Livré le 17 oct. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by bett brothers (arbroath) LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of charles dick & son limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 oct. 1980Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Letter of offset
    Créé le 14 nov. 1978
    Livré le 20 nov. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of charles dick & son LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 nov. 1978Enregistrement d'une charge
    • 02 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0