SUDAR MANUFACTURING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SUDAR MANUFACTURING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC025605 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SUDAR MANUFACTURING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Sherwood House, 7 Glasgow Road PA1 3QS Paisley |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SUDAR MANUFACTURING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour SUDAR MANUFACTURING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2008 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2007 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2006 | 6 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2005 | 5 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2004 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2003 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 225 | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2002 | 6 pages | AA | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2001 | 11 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 6 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 6 pages | 363s | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2000 | 11 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SUDAR MANUFACTURING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REID, Victoria Walker | Secrétaire | 23 Broomcroft Road Newton Mearns G77 5ER Glasgow | British | 702790003 | ||||||
| REID, Samuel Maurice | Administrateur | 23 Broomcroft Road Newton Mearns G77 5ER Glasgow | United Kingdom | British | 90340002 | |||||
| BEGG, John Alexander | Secrétaire | 92 Queensborough Gardens Hyndland G12 9RX Glasgow | British | 48867450001 | ||||||
| BROWN, Ian Marshall | Secrétaire | 20 Norwood Drive Giffnock G46 7LS Glasgow | British | 90330002 | ||||||
| CALDWELL, Allan Mackinnon | Secrétaire | Flat 5 Auckingramont Court 64 Union Street ML3 6NA Hamilton Lanarkshire | British | 30468210001 | ||||||
| CAMPBELL, James Mossman | Secrétaire | 23 Rubislaw Drive Bearsden G61 1PS Glasgow Lanarkshire Scotland | British | 9505320001 | ||||||
| HARKNESS, Duncan John | Secrétaire | 14 Douglas Gardens Uddingston G71 7HB Glasgow Lanarkshire | British | 58300001 | ||||||
| WARK, David Lewis | Secrétaire | 9 Waterside Avenue Newton Mearns G77 6TJ Glasgow | British | 46723000002 | ||||||
| BOYD, Joseph | Administrateur | 277 Eldon Street PA16 7QE Greenock Renfrewshire | British | 63741180001 | ||||||
| BROWN, Ian Marshall | Administrateur | 20 Norwood Drive Giffnock G46 7LS Glasgow | British | 90330002 | ||||||
| CUNNINGHAM, Thomas Rafferty | Administrateur | 45 Gallacher Green EH54 8RD Livingston West Lothian | United Kingdom | British | 67760160001 | |||||
| HACKING, Roy | Administrateur | 14 Shillingworth Place PA11 3DY Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 43409090001 | ||||||
| HARKNESS, Duncan John | Administrateur | 14 Douglas Gardens Uddingston G71 7HB Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 58300001 | |||||
| HOLMES, Isobel Margaret | Administrateur | 2 Uddingston Road Bothwell G71 8PG Glasgow Lanarkshire | British | 1376580001 | ||||||
| LURIE, Edward | Administrateur | Westlands Humbie Road Newton Mearns G77 5DF Glasgow Lanarkshire | British | 1101640001 | ||||||
| MARNIE, Alan | Administrateur | 115 Mote Hill ML3 6EA Hamilton Lanarkshire | United Kingdom | British | 63741020001 | |||||
| MOUG, George Boyd | Administrateur | Airlie Old Carlisle Road DG10 9QJ Moffat Dumfriesshire | British | 123380001 | ||||||
| POLET, Peter Damien | Administrateur | 4 Craigbet Place Quarriers Village PA11 3QT Bridge Of Weir Renfrewshire | United Kingdom | British | 90390002 | |||||
| REID, Ansley Mary | Administrateur | 9 Dunvegan Drive Newton Mearns G77 5EB Glasgow Lanarkshire | British | 90350001 | ||||||
| SHEFFIELD, Peter John Kirkham | Administrateur | Blyndley 30 Manse Street TD1 1NE Galashiels Selkirkshire | British | 56329360001 | ||||||
| VAUGHAN-JONES, Andrew Henry | Administrateur | 1 The Old Rectory Atherstone On Stour CV37 8NE Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 160531800001 | |||||
| WALLS, Stephen | Administrateur | 2 Fernleigh Close CA13 0NS Tallentire Cumbria | United Kingdom | British | 117807400001 | |||||
| WARK, David Lewis | Administrateur | 9 Waterside Avenue Newton Mearns G77 6TJ Glasgow | Scotland | British | 46723000002 | |||||
| WILLERTON, Peter James | Administrateur | 3 Burnside Avenue Brookfield PA5 8UT Johnstone Renfrewshire | British | 90370001 | ||||||
| WOOD, George Francis | Administrateur | 58 Wilton Road ML8 4LB Carluke Lanarkshire | Scotland | British | 425840001 |
SUDAR MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Créé le 22 avr. 1991 Livré le 30 avr. 1991 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All freehold property situate at and known as portrack industrial estate, portrack lane, stockton on tees. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 08 nov. 1989 Livré le 20 nov. 1989 | Partiellement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 02 nov. 1984 Livré le 15 nov. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Block 75 (1.21 hectares) hillington industrial estate, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Instrument of charge | Créé le 13 juin 1973 Livré le 04 juil. 1973 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from thecompany to the chargee but not exceeding£60,000 of principal. | |
Brèves mentions Whole of the property. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 27 nov. 1972 Livré le 01 déc. 1972 | Partiellement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0