ABERLOUR HOUSE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABERLOUR HOUSE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC025720
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABERLOUR HOUSE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ABERLOUR HOUSE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gordonstoun School
    Elgin
    IV30 5RF Morayshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ABERLOUR HOUSE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour ABERLOUR HOUSE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Bryan Peter Williams en tant que directeur le 03 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Professor Bryan Peter Williams en tant qu'administrateur le 03 oct. 2020

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Hugh Spence Brown en tant que secrétaire le 16 mai 2018

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Bryan Peter Williams en tant que directeur le 01 juin 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Yeoman en tant que directeur le 01 juin 2018

    1 pagesTM01

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2013 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 août 2011

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2012 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 août 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2011 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 août 2009

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2010 sans liste des membres

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bryan Peter Williams le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Yeoman le 01 mars 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 août 2008

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ABERLOUR HOUSE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARR, George Jefferson
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    Secrétaire
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    British38294790001
    BROWN, Hugh Spence
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    Secrétaire
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    British40872570003
    BROWN, James Ogg, Commander
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    Secrétaire
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    British37334700001
    SPENCER, John Robert, Squadron Leader
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    Secrétaire
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    British50650460002
    WHITTLE, Colin Douglas Richardson
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Secrétaire
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    British536270001
    BUCHANAN, Ewan Craig Barr
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    Administrateur
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    United KingdomBritish404330003
    CAUNT, Christine Janet
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    British5133580001
    DICKINSON, John Joicey
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    Administrateur
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    British1278160001
    DONALD, Charles
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    EnglandBritish69189660001
    DRUMMOND, Norman
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    British68147030002
    FARQUHARSON, Clodagh
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    Administrateur
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    British7047470001
    FERGUSON, James Gordon Dickson
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish23960001
    FOGDEN, Andrew Mark
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    British74942750002
    GORDON DUFF, Priscilla Margaret
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    Administrateur
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    KeithBritish47184790001
    GRUNEBAUM, George Peter
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    Administrateur
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    United StatesAmerican96073500001
    HILL, Caroline Elizabeth
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    Administrateur
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    British1054220001
    HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish69284900001
    HUNT, Flora Christine Campbell
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    British1323300001
    INGLEBY, Moira Frances
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    British45709310001
    ISMAY CHEAPE, Emma Margaret
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    Administrateur
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    British38383690001
    JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    Administrateur
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    ScotlandBritish1390490001
    LOCKE, Alasdair James Dougall
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    Administrateur
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    United KingdomBritish115457770001
    LUMLEY, Tessa Jocelyn
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Administrateur
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    British85182640001
    MACDONALD, Angus Stewart
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    Administrateur
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    British1220020001
    MARTIN, Hector John Bruce
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    Administrateur
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    British54403370002
    MATHEWSON, George
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    Administrateur
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    British1054210001
    MITCALFE, Alan Hugh
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    Administrateur
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    British8870980001
    MORGAN, Angus
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    Administrateur
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    British1142050001
    NASH, Mark Andrew
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    Administrateur
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    ScotlandBritish114921310001
    NICHOLSON, John Richard
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    Administrateur
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    United KingdomBritish1054200007
    NICHOLSON, John Richard
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    Administrateur
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    British1054200001
    OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    British45709230001
    ORD, Peter John
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish948580002
    RUANE, Richard James
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    Administrateur
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    British1293210002
    SABBAN-CLARKE, James Paley
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    Administrateur
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    British89104030001

    ABERLOUR HOUSE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 11 avr. 2002
    Livré le 30 avr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 nov. 1990
    Livré le 19 nov. 1990
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 nov. 1993Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Floating charge
    Créé le 01 août 1983
    Livré le 03 août 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £75,000 & all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transactions
    • 03 août 1983Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 25 juil. 1983
    Livré le 29 juil. 1983
    En cours
    Montant garanti
    £75,000,00
    Brèves mentions
    All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others.
    Personnes ayant droit
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transactions
    • 29 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    Disposition
    Créé le 29 sept. 1969
    Livré le 02 mars 1970
    En cours
    Montant garanti
    £4,000
    Brèves mentions
    New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire.
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Building Society
    Transactions
    • 02 mars 1970Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0