ABERLOUR HOUSE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ABERLOUR HOUSE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC025720 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ABERLOUR HOUSE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Gordonstoun School Elgin IV30 5RF Morayshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ABERLOUR HOUSE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour ABERLOUR HOUSE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Cessation de la nomination de Bryan Peter Williams en tant que directeur le 03 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Professor Bryan Peter Williams en tant qu'administrateur le 03 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Cessation de la nomination de Hugh Spence Brown en tant que secrétaire le 16 mai 2018 | 2 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Bryan Peter Williams en tant que directeur le 01 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Yeoman en tant que directeur le 01 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Ordonnance du tribunal Order of court - dissolution void | 1 pages | OC-DV | ||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2012 | 7 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2013 sans liste des membres | 4 pages | AR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 août 2011 | 10 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2012 sans liste des membres | 4 pages | AR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 août 2010 | 10 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2011 sans liste des membres | 4 pages | AR01 | ||
Comptes annuels établis au 31 août 2009 | 8 pages | AA | ||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 févr. 2010 sans liste des membres | 3 pages | AR01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bryan Peter Williams le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Yeoman le 01 mars 2010 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 août 2008 | 10 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de ABERLOUR HOUSE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARR, George Jefferson | Secrétaire | Gordonstoun School IV30 2RF Elgin Moray | British | 38294790001 | ||||||
| BROWN, Hugh Spence | Secrétaire | 13 Beech Brae IV30 4NS Elgin Moray | British | 40872570003 | ||||||
| BROWN, James Ogg, Commander | Secrétaire | The White House Duffus IV30 2QN Elgin Morayshire | British | 37334700001 | ||||||
| SPENCER, John Robert, Squadron Leader | Secrétaire | Kilcluan House IV30 8LA Elgin Morayshire | British | 50650460002 | ||||||
| WHITTLE, Colin Douglas Richardson | Secrétaire | 121 High Street IV36 1AB Forres | British | 536270001 | ||||||
| BUCHANAN, Ewan Craig Barr | Administrateur | Mayne House IV30 3RS Elgin Morayshire | United Kingdom | British | 404330003 | |||||
| CAUNT, Christine Janet | Administrateur | 43 Park Town OX2 6SL Oxford Oxfordshire | British | 5133580001 | ||||||
| DICKINSON, John Joicey | Administrateur | Dipple House IV32 7QA Fochabers Moray | British | 1278160001 | ||||||
| DONALD, Charles | Administrateur | Plow Green Hartley Wespall RG27 0AL Hook Hampshire | England | British | 69189660001 | |||||
| DRUMMOND, Norman | Administrateur | 24 Huntingdon Place EH7 4AX Edinburgh Midlothian | British | 68147030002 | ||||||
| FARQUHARSON, Clodagh | Administrateur | Dallas Lodge IV36 0RY Forres Moray | British | 7047470001 | ||||||
| FERGUSON, James Gordon Dickson | Administrateur | 25 Heriot Row EH3 6EN Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 23960001 | |||||
| FOGDEN, Andrew Mark | Administrateur | Wardsley Farmhouse Leagram Chipping PR3 2QT Preston Lancashire | British | 74942750002 | ||||||
| GORDON DUFF, Priscilla Margaret | Administrateur | Kirkton House Drummuir AB55 3JE Keith Banffshire | Keith | British | 47184790001 | |||||
| GRUNEBAUM, George Peter | Administrateur | 352 Mclain Street Bedford Hills New York 10507 Usa | United States | American | 96073500001 | |||||
| HILL, Caroline Elizabeth | Administrateur | Taylors Wynd Clocksbriggs DD8 2TA Forfar Angus | British | 1054220001 | ||||||
| HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne | Administrateur | Gatcombe Park Hampton Fields, Minchinhampton GL6 9AT Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 69284900001 | |||||
| HUNT, Flora Christine Campbell | Administrateur | 39 Stratherrick Road IV2 4LF Inverness Inverness Shire | British | 1323300001 | ||||||
| INGLEBY, Moira Frances | Administrateur | Invermarkie Glass AB54 4XY Huntly Aberdeenshire | British | 45709310001 | ||||||
| ISMAY CHEAPE, Emma Margaret | Administrateur | Middleton Fossoway KY13 6PB Kinross | British | 38383690001 | ||||||
| JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel | Administrateur | Spynie Kirk House Spynie IV30 8XJ Elgin Moray | Scotland | British | 1390490001 | |||||
| LOCKE, Alasdair James Dougall | Administrateur | Glenrinnes Lodge Dufftown AB55 4BS Keith Banffshire Scotland | United Kingdom | British | 115457770001 | |||||
| LUMLEY, Tessa Jocelyn | Administrateur | Flat 4 10 Westbourne Gardens W2 5PU London | British | 85182640001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Stewart | Administrateur | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross & Cromarty | British | 1220020001 | ||||||
| MARTIN, Hector John Bruce | Administrateur | Windmill Cottage 38 High Street AB38 9QD Aberlour Banffshire | British | 54403370002 | ||||||
| MATHEWSON, George | Administrateur | Netherfield Skye Of Kurr PH26 3PA Dulnain Bridge Grantown On Spey Moray | British | 1054210001 | ||||||
| MITCALFE, Alan Hugh | Administrateur | Milton Brodie IV36 0UA Forres Morayshire | British | 8870980001 | ||||||
| MORGAN, Angus | Administrateur | Mount Devon House FK14 7PT Dollar | British | 1142050001 | ||||||
| NASH, Mark Andrew | Administrateur | 54 Harbour Street IV30 5RU Hopeman Moray | Scotland | British | 114921310001 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Administrateur | Romach House Dunphail IV36 2QR Forres Morayshire | United Kingdom | British | 1054200007 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Administrateur | Mayne Lodge Mayne IV30 3SX Elgin Moray | British | 1054200001 | ||||||
| OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle | Administrateur | Netherdale House AB53 7LE Turriff Aberdeenshire | British | 45709230001 | ||||||
| ORD, Peter John | Administrateur | Baile Na Coille Balmoral AB35 5TB Ballater Aberdeenshire | Scotland | British | 948580002 | |||||
| RUANE, Richard James | Administrateur | Willow Vale Tradespark Road IV12 5NF Nairn Nairnshire | British | 1293210002 | ||||||
| SABBAN-CLARKE, James Paley | Administrateur | Sandy Hill Farm Corfe Castle BH20 5JF Wareham Dorset | British | 89104030001 |
ABERLOUR HOUSE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Créé le 11 avr. 2002 Livré le 30 avr. 2002 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 05 nov. 1990 Livré le 19 nov. 1990 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 01 août 1983 Livré le 03 août 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti £75,000 & all further sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 25 juil. 1983 Livré le 29 juil. 1983 | En cours | Montant garanti £75,000,00 | |
Brèves mentions All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Disposition | Créé le 29 sept. 1969 Livré le 02 mars 1970 | En cours | Montant garanti £4,000 | |
Brèves mentions New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0