SC026103 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSC026103 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC026103
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SC026103 LIMITED ?

    • (3420) /

    Où se situe SC026103 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor
    Saltire Court
    EH1 2EN 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SC026103 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WALTER ALEXANDER & COMPANY (COACHBUILDERS) LIMITED16 févr. 194816 févr. 1948

    Quels sont les derniers comptes de SC026103 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2002

    Quels sont les derniers dépôts pour SC026103 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    3 pagesOC-DV

    Certificat de changement de nom

    Company name changed walter alexander (falkirk)\certificate issued on 13/05/21
    pagesCERTNM

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    26 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de SC026103 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAYFLOWER MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    Secrétaire
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    97789670001
    MAYFLOWER MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    Administrateur
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    97789670001
    THE MAYFLOWER CORPORATION PLC
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Administrateur
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    102132700001
    CHALMERS, Nicholas Oman
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    British1158020002
    GRANT, John Rattray
    38 Laurelhill Place
    FK8 2JJ Stirling
    Stirlingshire
    Secrétaire
    38 Laurelhill Place
    FK8 2JJ Stirling
    Stirlingshire
    British628900001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Secrétaire
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    613080003
    ALEXANDER, Cyril James Turnbull
    Woodside
    FK14 7JX Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    Woodside
    FK14 7JX Dollar
    Clackmannanshire
    British181360001
    ALEXANDER, Walter Ronald
    Moonzie Mill
    Balmullo
    KY16 0AH St Andrews
    Fife
    Administrateur
    Moonzie Mill
    Balmullo
    KY16 0AH St Andrews
    Fife
    British177410002
    BARR, Maurice James
    118 Currieside Avenue
    ML7 4AX Shotts
    Lanarkshire
    Administrateur
    118 Currieside Avenue
    ML7 4AX Shotts
    Lanarkshire
    British38165900001
    CAMERON, William
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    Administrateur
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    British15243740003
    CARDOW, Robert Stuart
    Westhills
    Bowfield Road
    PA9 1BS Howwood
    Renfrewshire
    Administrateur
    Westhills
    Bowfield Road
    PA9 1BS Howwood
    Renfrewshire
    British40276190001
    CHALMERS, Nicholas Oman
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    British1158020002
    CHAPMAN, Michael
    93 Broadway
    Duffield
    DE56 4BW Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    93 Broadway
    Duffield
    DE56 4BW Belper
    Derbyshire
    British58307070001
    COLE, Alan Jack
    30 Broughton Place
    EH1 3RT Edinburgh
    Administrateur
    30 Broughton Place
    EH1 3RT Edinburgh
    British9811630002
    CRAMB, Raymond Peter
    31 The Bridges
    KY11 9XZ Dalgety Bay
    Fife
    Administrateur
    31 The Bridges
    KY11 9XZ Dalgety Bay
    Fife
    British81978110001
    DONNELLY, David Thomas
    Sherbourne
    Glendene Avenue
    KT24 5AY East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Sherbourne
    Glendene Avenue
    KT24 5AY East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish34478650003
    DUFFIN, Ian Andrew
    Crosswinds
    2 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxon
    Administrateur
    Crosswinds
    2 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxon
    British63643820001
    FLEMING, John
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    Administrateur
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    British107749800001
    FULTON, Charles Mcmillan
    10 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NY Glasgow
    Administrateur
    10 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NY Glasgow
    British42783750001
    GALLACHER, John James
    92a Maxwellton Avenue
    East Kilbride
    G74 3DY Glasgow
    Administrateur
    92a Maxwellton Avenue
    East Kilbride
    G74 3DY Glasgow
    British51332140001
    GALLOWAY, Ian William
    Dundarroch
    Lochard Roa
    FK8 3TQ Aberfoyle
    Stirling
    Administrateur
    Dundarroch
    Lochard Roa
    FK8 3TQ Aberfoyle
    Stirling
    British1051370004
    HASTIE, James
    64a Colquhoun Street
    G84 9JP Helensburgh
    Administrateur
    64a Colquhoun Street
    G84 9JP Helensburgh
    ScotlandBritish36987530002
    HODGSON, Clive John Peter
    Locka Oldhall
    Locka Lane Arkholme
    LA6 1BD Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Locka Oldhall
    Locka Lane Arkholme
    LA6 1BD Carnforth
    Lancashire
    British32698020001
    HUNT, Colin Maxwell
    Twynham
    1 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Twynham
    1 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    British63787560001
    KERR, Ian William
    42 Redding Road
    Laurieston
    FK2 9JU Falkirk
    Administrateur
    42 Redding Road
    Laurieston
    FK2 9JU Falkirk
    British38447970001
    KEYS, William Wesley
    The Pines
    FK14 7AE Dollar
    Administrateur
    The Pines
    FK14 7AE Dollar
    British628910001
    LAWRENCE, John Malcolm
    The Paddock Second Drift
    Wothorpe
    PE9 3JH Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    The Paddock Second Drift
    Wothorpe
    PE9 3JH Stamford
    Lincolnshire
    British1271680001
    MARTIN, David Stuart
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    British70256380001
    MATHIESON, Malcolm
    16 Bonnyview Gardens
    FK4 1PW Bonnybridge
    Stirlingshire
    Administrateur
    16 Bonnyview Gardens
    FK4 1PW Bonnybridge
    Stirlingshire
    ScotlandBritish59765780001
    MCGAUGHEY, Goodlet William Nigel
    Dripend Farm
    FK9 4UJ Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    Dripend Farm
    FK9 4UJ Stirling
    Stirlingshire
    British67292900001
    MCLEAN, Ross
    51 Ewenfield Avenue
    KA7 2QL Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    51 Ewenfield Avenue
    KA7 2QL Ayr
    Ayrshire
    British74820480001
    PITKIN, Frank John
    10b Fort End
    HP17 8EJ Haddenham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10b Fort End
    HP17 8EJ Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish87977780001
    RHODES, Glenn Martin
    26 Forth Crescent
    FK8 1LG Stirling
    Administrateur
    26 Forth Crescent
    FK8 1LG Stirling
    British38165730002
    SIMPSON, John William Peter
    Portnall Hill
    Portnall Drive Wentworth
    GU25 4NW Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Portnall Hill
    Portnall Drive Wentworth
    GU25 4NW Virginia Water
    Surrey
    British36520000001
    STEWART, James Roy
    2 Balmore Court
    PA13 4LX Kilmacolm
    Renfrewshire
    Administrateur
    2 Balmore Court
    PA13 4LX Kilmacolm
    Renfrewshire
    ScotlandBritish68035790001

    SC026103 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 11 juin 1993
    Livré le 29 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    91 glasgow road falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 29 juin 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 déc. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 1992
    Livré le 10 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    91 glasgow road, camelon, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 avr. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 02 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 02 avr. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 20 déc. 1991
    Livré le 03 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 janv. 1992Enregistrement d'une charge
    • 16 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 juin 1990
    Livré le 29 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Those areas of ground extending to: (1) 0.130 acre (2) 4 acres 2 roods 16 poles 26 sq. Yards (but excepting 0.068 acre and 85.12 sq. Yards therefrom) (3) (I) 7 acres (but excepting 0.162 acre therefrom) (ii) 28 poles (but excepting 0.175 acre therefrom) (4) 2 acres 25 poles (5) 1.1 acre and (6) 0.43 acre, in falkirk, stirling.
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bank
    Transactions
    • 29 juin 1990Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 13 juin 1990
    Livré le 03 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Security Pacific National Bank
    Transactions
    • 03 juil. 1990Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0