BIKECLOUD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBIKECLOUD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC027672
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BIKECLOUD LIMITED ?

    • Fabrication d'instruments et fournitures médicaux et dentaires (32500) / Industries manufacturières

    Où se situe BIKECLOUD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BIKECLOUD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WALLACE, CAMERON & COMPANY LIMITED25 avr. 195025 avr. 1950

    Quels sont les derniers comptes de BIKECLOUD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BIKECLOUD LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BIKECLOUD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    16 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 26 Netherhall Road Netherton Industrial Est Wishaw Lanarkshire ML2 0JG* le 01 août 2013

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Certificat de changement de nom

    Company name changed wallace, cameron & company LIMITED\certificate issued on 29/05/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    29 mai 2013

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Statuts

    30 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Giovanni Benedetti en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Andrew Palmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Palmer en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG03s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2012

    État du capital au 12 juin 2012

    • Capital: GBP 1,856,766
    SH01

    legacy

    3 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de Paul Anderson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Mallard en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Mallard en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Andrew Palmer en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de Andrew Palmer en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Graeme Carruthers en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    5 pagesMG01s

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BIKECLOUD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENEDETTI, Giovanni
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Secrétaire
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    175991450001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Administrateur
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    United KingdomItalian90520001
    LENNOX, Alexander Craig
    2 Dunmore Drive
    Milngavie
    G62 6NZ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    Secrétaire
    2 Dunmore Drive
    Milngavie
    G62 6NZ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    British47685000001
    MALLARD, Ian
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    Secrétaire
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    British146386340001
    PALMER, Andrew
    Borland Road
    G61 2ND Bearsden
    37
    Secrétaire
    Borland Road
    G61 2ND Bearsden
    37
    British163906450001
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secrétaire
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    British53458580003
    ANDERSON, Paul
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Scotland United Kingdom
    Administrateur
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Scotland United Kingdom
    ScotlandBritish160040730001
    CARRUTHERS, Graeme Frank Hamilton
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    Wallace Ameron & Co Ltd
    Administrateur
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    Wallace Ameron & Co Ltd
    ScotlandBritish147817050001
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    British111876120001
    CRANSTON, Charles Johnstone
    Heathland 85 Woolsbridge Road
    Ashley Heath
    BH24 2LY Ringwood
    Hampshire
    Administrateur
    Heathland 85 Woolsbridge Road
    Ashley Heath
    BH24 2LY Ringwood
    Hampshire
    British1322560003
    DENHURST, Mark
    Millhill Crescent
    FK15 0LH Greenloaning
    8
    Perthshire
    Administrateur
    Millhill Crescent
    FK15 0LH Greenloaning
    8
    Perthshire
    British130744440001
    FRYER, Alan Richmond
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    Administrateur
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    British9290001
    HOLBROOK, Paul
    Oak Cottage
    School Lane, Burwardsley
    CH3 9NX Chester
    Cheshire
    Administrateur
    Oak Cottage
    School Lane, Burwardsley
    CH3 9NX Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish151168180001
    HUGHES, Adrian John David
    29 Wakehurst Drive
    NN4 0TN Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    29 Wakehurst Drive
    NN4 0TN Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish67694050001
    JACK, Sheena Buchanan
    Nursery Drive
    Dalgarven Meadows
    KA13 6EL Kilwinning
    28
    Administrateur
    Nursery Drive
    Dalgarven Meadows
    KA13 6EL Kilwinning
    28
    ScotlandBritish161099050001
    KEMP, Kenneth Reginald
    29 Batchelors Way
    HP7 9AH Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    29 Batchelors Way
    HP7 9AH Amersham
    Buckinghamshire
    British28260001
    LAURI, Toomas Rein
    32 Avenue De Miremont
    1206
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    Administrateur
    32 Avenue De Miremont
    1206
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    Swedish1128790001
    MACKAY, Ian Duncan
    Glenairthrey
    12 Upper Glen Road
    FK9 4PX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Administrateur
    Glenairthrey
    12 Upper Glen Road
    FK9 4PX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British74583500001
    MALLARD, Ian
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    Administrateur
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    UkBritish146386250001
    MCCORMICK, John Robert
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    Administrateur
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    ScotlandBritish82210090001
    NEILSON, Iain Macarthur Blackadder
    30 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    30 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Lanarkshire
    British9280001
    OWENS, Anthony
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    Administrateur
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish86285020002
    PALMER, Andrew Grant Dougal
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Administrateur
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    ScotlandBritish176138150001
    PITTMAN, Philip John
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish115658830001
    REILLY, Brennan Michael
    17 Glenpark Avenue
    Thornliebank
    G46 7JE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    17 Glenpark Avenue
    Thornliebank
    G46 7JE Glasgow
    Lanarkshire
    British52482110002
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Administrateur
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    United KingdomBritish53458580003
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Administrateur
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    United KingdomBritish53458580003

    BIKECLOUD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 13 juin 2011
    Livré le 17 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 17 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 03 août 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 03 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 janv. 2008
    Livré le 06 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 06 févr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 22 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 22 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 1999
    Livré le 19 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 déc. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 oct. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 1999
    Livré le 19 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Giovanni Benedetti
    Transactions
    • 19 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 déc. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 oct. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 21 oct. 1993
    Livré le 26 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property known as all and whole the tenants' interest under the lease of the property known as ultra house, drakemire drive, castlemilk, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 19 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 oct. 1993
    Livré le 27 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 déc. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 oct. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 19 oct. 1993
    Livré le 26 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 oct. 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 déc. 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 oct. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    BIKECLOUD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 avr. 2015Conclusion of winding up
    19 juil. 2013Petition date
    19 juil. 2013Commencement of winding up
    02 juil. 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Nigel Mckay
    Lomond House, 9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    practitioner
    Lomond House, 9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    practitioner
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0