A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED

A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéA. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC029680
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    • (5231) /

    Où se situe A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Robert Owen House
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 janv. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 27 févr. 2014

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Alan Harrison en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pagesAC93

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2011

    État du capital au 05 mai 2011

    • Capital: GBP 5,500
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony John Smith le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Branson Nuttall le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan John Harrison le 31 juil. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 02 janv. 2010

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Alan John Harrison le 21 mars 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Peter Batty en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 10 janv. 2009

    25 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Brocklehurst en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle raccourcie du 11 janv. 2010 au 04 janv. 2010

    1 pagesAA01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Robert Owen House
    Secrétaire
    87 Bath Street
    G2 2EE Glasgow
    Robert Owen House
    150340080001
    NUTTALL, John Branson
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish137558680001
    COOK, Margaret Kerr
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    Secrétaire
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    British436100003
    COOK, Philippa Betty
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Secrétaire
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Australian84440150003
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Administrateur
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    COOK, Margaret Kerr
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    14 Westpark Gate
    Saline
    KY12 9US Dunfermline
    Fife
    British436100003
    COOK, Peter James Henderson
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Administrateur
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    British809330007
    COOK, Philippa Betty
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Administrateur
    Gwydyr House
    Comrie Road
    PH7 4BP Crieff
    Perthshire
    Australian84440150003
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Administrateur
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    HARRISON, Alan John
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Governance Department
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    ScotlandBritish97831730001
    KENT, Ronald
    5 Christie Street
    KY12 0AQ Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    5 Christie Street
    KY12 0AQ Dunfermline
    Fife
    British436110001
    NOBLE, Spencer John
    23 Hallowes Drive
    S18 1YH Sheffield
    Yorkshire
    Administrateur
    23 Hallowes Drive
    S18 1YH Sheffield
    Yorkshire
    EnglandBritish115498920001

    A. ROBERTSON & SON (CHEMISTS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of goodwill
    Créé le 24 avr. 2007
    Livré le 27 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company - see form 410 for more details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aah Pharmaceuticals LTD and Another
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of goodwill
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 20 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company at 64 bank street, lochgelly together with the exclusive right for the bank to carry on the said pharmacy business under the name of 'A. robertson & son (chemists) limited', or such other name or names as may be approved by the bank in writing and the benefit of all rights and privileges accruing thereto and remedies for enforcing the same and respectively to represent the bank as carrying on the said pharmacy business in succession t o the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of goodwill
    Créé le 10 févr. 2006
    Livré le 20 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The goodwill, custom and connection of the company in relation to the pharmacy business carried on by the company at elliot street, dunfermline together with the exclusive right for the bank to carry on the said pharmacy business under the name of 'A. robertson & son (chemists) limited', or such other name or names as may be approved by the bank in writing and the benefit of all rights and privileges accruing thereto and remedies for enforcing the same and respectively to represent the bank as carrying on the said pharmacy business in succession to the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    18 douglas street, dunfermline, fife ffe 3636.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 26 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 déc. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 09 sept. 1995
    Livré le 29 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £105,000
    Brèves mentions
    18/20 douglas street, dunfermline, fife.
    Personnes ayant droit
    • Mrs Margaret Kerr Cook
    Transactions
    • 29 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 oct. 1989
    Livré le 01 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0