VION SUBCO MD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVION SUBCO MD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC030556
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VION SUBCO MD LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe VION SUBCO MD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VION SUBCO MD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MCINTOSH DONALD LIMITED06 mars 198906 mars 1989
    WILLIAM DONALD & SON (WHOLESALE MEAT CONTRACTORS) LIMITED31 janv. 195531 janv. 1955

    Quels sont les derniers comptes de VION SUBCO MD LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2014
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2015
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour VION SUBCO MD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    9 pages4.26(Scot)

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA à C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 23 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 avr. 2015

    LRESSP

    État du capital au 24 févr. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced 23/02/2015
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2014

    État du capital au 04 nov. 2014

    • Capital: GBP 1,978,570
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    6 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* le 12 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 oct. 2013

    État du capital au 09 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,978,570
    SH01

    Cessation de la nomination de Jose Peralta en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Leon Barry Abbitt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Steven en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Louis Vernaus en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Maarten Kusters en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed mcintosh donald LIMITED\certificate issued on 04/04/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 avr. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name04 avr. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    legacy

    12 pagesMG01s

    legacy

    9 pagesMG01s

    Qui sont les dirigeants de VION SUBCO MD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director153119640001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British388530001
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    British138570001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BUCHAN, Eric
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Glenisla
    Grampian Terrace, Torphins
    AB31 4JS Banchory
    Kincardineshire
    BritishProcurement Director91024360001
    BUCHAN, Ian
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    26 Belvidere Street
    AB2 4QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishFinancial Director388530001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    DutchDirector129239540002
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishCompany Director402690001
    DUNCAN, Gordon Scott
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Tigh Na Bruich Feuchside
    Strachan
    Banchory
    Kincardineshire
    BritishProperty Consultant33741760001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director105961550001
    GREEN, Ralph
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    37 Rutherford Folds
    AB51 4JH Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishCommercial Manager56693150001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishAccountant63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutchCeo167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Administrateur
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    DutchChief Financial Officer126350570004
    LIND, John
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Overton Of Keithfield
    AB41 0EU Methlick
    Aberdeenshire
    United KingdomBritishConsultant515220001
    MCNAUGHTON, Alan John
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Ashlade
    Waulkmill Farm
    AB30 1EJ Laurencekirk
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishSales Director44916150002
    MELVIN, John Robertson
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    18 Moray Place
    AB15 4AG Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSolicitor134100002
    NAPIER, Keith Graham
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    302 Queens Road
    AB1 8DT Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSolicitor138570001
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    BritishCompany Director338220001
    PERALTA, Jose Juan
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomCanadianManaging Director55989090003
    POCOCK, Patrick William
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    Administrateur
    55 Millside Road
    Peterculter
    AB1 0WE Aberdeen
    Grampian
    BritishChartered Accountant36234170001
    PROVAN, James Lyal Clark
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    Administrateur
    Wallacetown
    Bridge Of Earn
    PH2 8QA Perth
    BritishEec Affairs Consultant1041290001
    RHIND, Evelyn Kerr
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Dearg Sheiling
    Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    BritishCompany Director389060001
    RHIND, John
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Dearg Sheiling
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    BritishRetired Farmer389050001
    ROEBUCK, Robert Isla
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    Administrateur
    Balquharn Farmhouse
    Badentoy Road
    Portlethen
    Aberdeen
    BritishSales Director56693510004
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director111995510001
    SOBEY, Michael John
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    Administrateur
    Overton Of Keithfield
    Methlick
    Ellon
    United KingdomBritishAccountant895550001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director338210001
    STEPHEN, Eric John
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Rosebank, Mainstreet
    Rothienorman
    AB51 8UD Inverurie
    Aberdeenshire
    BritishFarmer441180002
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritishFinance Director159788300001
    STRACHAN, Wilfred
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Denview
    Kingswells
    AB1 8PT Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishProcurement Officer388540001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Director146206430001

    VION SUBCO MD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second ranking security agreement
    Créé le 02 oct. 2012
    Livré le 12 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First ranking security agreement
    Créé le 02 oct. 2012
    Livré le 12 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1998
    Livré le 24 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 sept. 1998
    Livré le 06 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The meat factory and others,portlethen,kincardineshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 06 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 juil. 1998
    Livré le 14 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 14 août 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 août 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 sept. 1996
    Livré le 20 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The meat factory,portlethen and other properties...............see ch paper apart 2 on ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 sept. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 sept. 1995
    Livré le 19 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The meat factory, portlethen and other properties........ See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 19 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mars 1995
    Livré le 11 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See page 2 of doc.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 mars 1995
    Livré le 28 mars 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee of Others
    Transactions
    • 28 mars 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 août 1993
    Livré le 27 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Obligations contained in missivesdated 23RD april, 5TH, 10TH (2 letters), 12TH, 24TH and 25TH all days of may 1993
    Brèves mentions
    (1ST) 3 strips of ground part of the farm and lands of milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire as relative to disposition by mcintosh donald LTD ifo malcolm allan housebuilders LTD dated 30TH july and recorded grs aberdeen 18TH aug 1993. (2ND) 1,840 square metres part of the alford branch railway line in said parish described in disposition by grampian regional council ifo mcintosh donald LTD dated 26TH july and recorded grs aberdeen 4TH nov 1991.
    Personnes ayant droit
    • Malcolm Allan Housebuilders Limited
    Transactions
    • 27 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 avr. 1991
    Livré le 15 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The meat factory portlellen kincardinshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 mai 1988
    Livré le 24 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 juin 1980
    Livré le 03 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Farms and lands of damhead of minnes, foveran, aberdeenshire cockley, maryculter, kincardineshire milton of kemnay, kemnay, aberdeenshire hill of minnes, foveran, aberdeenshire mains of badentoy, portlethen, kincardineshire the farming unit of balquharn, cookston, eskywell and the lands of craighead, portlethen, kincardineshire extending in all to one thousand two hundred and seventy acres or thereby.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 03 juil. 1980Enregistrement d'une charge

    VION SUBCO MD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 avr. 2017Due to be dissolved on
    10 avr. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0