SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED

SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC032304
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage

    Où se situe SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    12 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX à C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ le 26 oct. 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de First Floor Maxim Business Park Maxim 1 2 Parklands Way Eurocentral Motherwell ML1 4WR Scotland à C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 05 avr. 2022

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mars 2022

    LRESSP

    Satisfaction de la charge SC0323040019 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0323040016 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2020 au 30 juin 2021

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge SC0323040022 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC0323040018 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0323040021 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    27 pagesAA

    Satisfaction de la charge SC0323040020 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0323040017 en totalité

    4 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Wilson Road Garage Newhouse Lanarkshire ML1 5NB à First Floor Maxim Business Park Maxim 1 2 Parklands Way Eurocentral Motherwell ML1 4WR le 21 août 2020

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Timothy Ward en tant que directeur le 01 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Ross Jamieson en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr. James Patrick Hemingway en tant qu'administrateur le 16 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    26 pagesAA

    Inscription de la charge SC0323040022, créée le 10 sept. 2018

    10 pagesMR01

    Nomination de Mr James Patrick Hemingway en tant que secrétaire le 24 août 2018

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEMINGWAY, James Patrick
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Secrétaire
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    249767900001
    ANDERSON, Samuel Irvine
    Pottishaw Farm
    EH48 2HU Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    Pottishaw Farm
    EH48 2HU Bathgate
    West Lothian
    ScotlandBritishCompany Director108693320001
    HEMINGWAY, James Patrick
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Administrateur
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    EnglandBritishFinance Director254719610001
    JAMIESON, Andrew Ross
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Administrateur
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    EnglandBritishChief Executive Officer126343470001
    ANDERSON, Isabella Mason Graham
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    Secrétaire
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    British1940001
    ANDERSON, Jennifer Isabella
    Beechwood
    Wilson Road
    ML1 5NB Newhouse
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Beechwood
    Wilson Road
    ML1 5NB Newhouse
    Lanarkshire
    British101363690001
    BROOKS, Robert Paul
    Drumellan Road
    Alloway
    KA7 4XA Ayr
    44
    Scotland
    Secrétaire
    Drumellan Road
    Alloway
    KA7 4XA Ayr
    44
    Scotland
    190873130001
    ANDERSON, Isabella Mason Graham
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    Administrateur
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    BritishSecretary1940001
    ANDERSON, Jennifer Isabella
    Beechwood
    Wilson Road
    ML1 5NB Newhouse
    Lanarkshire
    Administrateur
    Beechwood
    Wilson Road
    ML1 5NB Newhouse
    Lanarkshire
    ScotlandBritishHaulage Operator101363690001
    ANDERSON, Peter Irvine
    Pottishaw Farm
    EH48 2HU Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    Pottishaw Farm
    EH48 2HU Bathgate
    West Lothian
    BritishHaulier1970002
    ANDERSON, Samuel
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    Administrateur
    Jesmar
    Newhouse
    ML1 5NB Motherwell
    BritishHaulier1950001
    ANDERSON, Samuel Stewart
    Main Street
    Overtown
    ML2 0QF Wishaw
    85
    Lanarkshire
    Administrateur
    Main Street
    Overtown
    ML2 0QF Wishaw
    85
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director655850002
    WARD, Timothy
    Newhouse
    ML1 5NB Lanarkshire
    Wilson Road Garage
    Administrateur
    Newhouse
    ML1 5NB Lanarkshire
    Wilson Road Garage
    EnglandBritishChief Executive106417640001
    WINNING, William
    28 Shottsburn Road
    Salsburgh
    ML7 4NT Shotts
    Lanarkshire
    Administrateur
    28 Shottsburn Road
    Salsburgh
    ML7 4NT Shotts
    Lanarkshire
    BritishAccountant1980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mrs Jillian Marion Mark
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    06 avr. 2016
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Northern Ireland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Miss Helena Anderson
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    06 avr. 2016
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Samuel Irvine Anderson
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    06 avr. 2016
    2 Atlantic Square
    31 York Street
    G2 8NJ Glasgow
    C/O Bdo Llp
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 sept. 2018
    Livré le 15 sept. 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Ground extending to 66.35 acres or therby at pottishaw farm, bathgate. Please see instrument for further details.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 juil. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 déc. 2017
    Livré le 16 déc. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Wilson road, newhouse. LAN232842.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 janv. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2017
    Livré le 15 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Stoneypath tower, haddington, ELN4840.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2017
    Livré le 15 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects comprising ten areas of ground at newmains, wishaw, LAN98325.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 févr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2017
    Livré le 15 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    30 westport, lanark, LAN134169 and the subjects lying to the north east of westport, lanark, LAN133827.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 mai 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2017
    Livré le 15 juin 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the subjects comprising an area of ground at crookston, musselburgh, MID75234.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 23 mai 2017
    Livré le 24 mai 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 févr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 30 westport, lanark (title numbers LAN134169 and LAN133827).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 40 hectares at stoneypath tower, haddington (title number ELN4840).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 91 acres at newmains, lanarkshire (title number LAN98325).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 19 dundyvan road, coatbridge (title number LAN122099).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming westburn farm road, cambuslang (title number LAN118825).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects at north faulds road, caldwellside industrial estate, lanark (title number LAN75459).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects at standhill, bathgate (title number WLN6963).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming 1 acre at crookston, musselburgh (title number MID75234).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    That plot of ground situated southeast of the public road leading from hareshaw to salsburgh containing 4.860 acres within the parish of shotts and county of lanark.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    The tenant's interest in the lease of subjects at an aird, fort william (title number INV5770).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 juil. 2005
    Livré le 11 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005
    Brèves mentions
    That area of ground extending to 66.35 acres at pottishaw farm, bathgate.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 04 juil. 2005
    Livré le 06 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 24 juin 2005
    Livré le 01 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The company agrees to pay to the bank the debt when the bank demands in writing
    Brèves mentions
    Legal charge over the freehold property known as land and buildings on the north east side of powke lane, old hill, west midlands wr 4783.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 27 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 févr. 1997
    Livré le 04 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 mars 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond for cash credit & floating charge
    Créé le 12 déc. 1968
    Livré le 20 déc. 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Commercial Bank of Scotland Limited
    Transactions
    • 20 déc. 1968Enregistrement d'une charge
    • 01 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 nov. 2023Due to be dissolved on
    30 mars 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0