SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC032304 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 12 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX à C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ le 26 oct. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de First Floor Maxim Business Park Maxim 1 2 Parklands Way Eurocentral Motherwell ML1 4WR Scotland à C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 05 avr. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040019 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040016 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2020 au 30 juin 2021 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040022 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040018 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040021 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 27 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040020 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC0323040017 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Wilson Road Garage Newhouse Lanarkshire ML1 5NB à First Floor Maxim Business Park Maxim 1 2 Parklands Way Eurocentral Motherwell ML1 4WR le 21 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Ward en tant que directeur le 01 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Ross Jamieson en tant qu'administrateur le 01 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 27 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr. James Patrick Hemingway en tant qu'administrateur le 16 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 26 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge SC0323040022, créée le 10 sept. 2018 | 10 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Patrick Hemingway en tant que secrétaire le 24 août 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMINGWAY, James Patrick | Secrétaire | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | 249767900001 | |||||||
ANDERSON, Samuel Irvine | Administrateur | Pottishaw Farm EH48 2HU Bathgate West Lothian | Scotland | British | Company Director | 108693320001 | ||||
HEMINGWAY, James Patrick | Administrateur | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | England | British | Finance Director | 254719610001 | ||||
JAMIESON, Andrew Ross | Administrateur | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | England | British | Chief Executive Officer | 126343470001 | ||||
ANDERSON, Isabella Mason Graham | Secrétaire | Jesmar Newhouse ML1 5NB Motherwell | British | 1940001 | ||||||
ANDERSON, Jennifer Isabella | Secrétaire | Beechwood Wilson Road ML1 5NB Newhouse Lanarkshire | British | 101363690001 | ||||||
BROOKS, Robert Paul | Secrétaire | Drumellan Road Alloway KA7 4XA Ayr 44 Scotland | 190873130001 | |||||||
ANDERSON, Isabella Mason Graham | Administrateur | Jesmar Newhouse ML1 5NB Motherwell | British | Secretary | 1940001 | |||||
ANDERSON, Jennifer Isabella | Administrateur | Beechwood Wilson Road ML1 5NB Newhouse Lanarkshire | Scotland | British | Haulage Operator | 101363690001 | ||||
ANDERSON, Peter Irvine | Administrateur | Pottishaw Farm EH48 2HU Bathgate West Lothian | British | Haulier | 1970002 | |||||
ANDERSON, Samuel | Administrateur | Jesmar Newhouse ML1 5NB Motherwell | British | Haulier | 1950001 | |||||
ANDERSON, Samuel Stewart | Administrateur | Main Street Overtown ML2 0QF Wishaw 85 Lanarkshire | Scotland | British | Company Director | 655850002 | ||||
WARD, Timothy | Administrateur | Newhouse ML1 5NB Lanarkshire Wilson Road Garage | England | British | Chief Executive | 106417640001 | ||||
WINNING, William | Administrateur | 28 Shottsburn Road Salsburgh ML7 4NT Shotts Lanarkshire | British | Accountant | 1980001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mrs Jillian Marion Mark | 06 avr. 2016 | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Northern Ireland | |||
Nature du contrôle
| |||
Miss Helena Anderson | 06 avr. 2016 | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Mr Samuel Irvine Anderson | 06 avr. 2016 | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
|
SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 10 sept. 2018 Livré le 15 sept. 2018 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Ground extending to 66.35 acres or therby at pottishaw farm, bathgate. Please see instrument for further details. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 14 déc. 2017 Livré le 16 déc. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Wilson road, newhouse. LAN232842. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2017 Livré le 15 juin 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Stoneypath tower, haddington, ELN4840. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2017 Livré le 15 juin 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects comprising ten areas of ground at newmains, wishaw, LAN98325. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2017 Livré le 15 juin 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description 30 westport, lanark, LAN134169 and the subjects lying to the north east of westport, lanark, LAN133827. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2017 Livré le 15 juin 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All and whole the subjects comprising an area of ground at crookston, musselburgh, MID75234. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 23 mai 2017 Livré le 24 mai 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming 30 westport, lanark (title numbers LAN134169 and LAN133827). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming 40 hectares at stoneypath tower, haddington (title number ELN4840). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming 91 acres at newmains, lanarkshire (title number LAN98325). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming 19 dundyvan road, coatbridge (title number LAN122099). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming westburn farm road, cambuslang (title number LAN118825). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects at north faulds road, caldwellside industrial estate, lanark (title number LAN75459). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects at standhill, bathgate (title number WLN6963). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The subjects known as and forming 1 acre at crookston, musselburgh (title number MID75234). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions That plot of ground situated southeast of the public road leading from hareshaw to salsburgh containing 4.860 acres within the parish of shotts and county of lanark. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions The tenant's interest in the lease of subjects at an aird, fort william (title number INV5770). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 05 juil. 2005 Livré le 11 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 14 june 2005 | |
Brèves mentions That area of ground extending to 66.35 acres at pottishaw farm, bathgate. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 04 juil. 2005 Livré le 06 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 24 juin 2005 Livré le 01 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti The company agrees to pay to the bank the debt when the bank demands in writing | |
Brèves mentions Legal charge over the freehold property known as land and buildings on the north east side of powke lane, old hill, west midlands wr 4783. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 21 févr. 1997 Livré le 04 mars 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond for cash credit & floating charge | Créé le 12 déc. 1968 Livré le 20 déc. 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
|
SAM ANDERSON (NEWHOUSE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0