SEMPLE PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEMPLE PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC032434
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEMPLE PLC ?

    • (4531) /

    Où se situe SEMPLE PLC ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton Uk Llp
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEMPLE PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SEMPLE COCHRANE PLC25 nov. 199625 nov. 1996
    SEMPLE & COCHRANE, LIMITED04 juil. 195704 juil. 1957

    Quels sont les derniers comptes de SEMPLE PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour SEMPLE PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis de cessation d'activité en tant que séquestre ou gérant

    1 pages3(Scot)

    Avis du rapport du séquestre

    6 pages3.5(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    3 pages1(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 30 juin 2004

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2003

    18 pagesAA

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    1 pages122

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages244

    Comptes consolidés établis au 30 juin 2002

    34 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de SEMPLE PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVANS, William Wilson
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    Secrétaire
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    British414930001
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Secrétaire
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    British36657620002
    HYND, Russell John
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    British62990090002
    MCKENDRICK, Ian Dempster
    Craigmiln
    G63 9EX Strathblane
    Secrétaire
    Craigmiln
    G63 9EX Strathblane
    British7650001
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secrétaire
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    ALLISON, Thomas Eardley
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    Administrateur
    Rockdale Lodge
    23 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Scotland
    ScotlandBritish1037730004
    AVERY, Stephen John
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    Administrateur
    32c Kenilworth Road
    FK9 4EH Bridge Of Allan
    Stirling
    United KingdomBritish73550410001
    BANNATYNE, Brian
    Ormlie
    Bankend Road
    PA11 3EU Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    Ormlie
    Bankend Road
    PA11 3EU Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandBritish49359160003
    BEATY, Robert Thompson, Professor
    Glenside 89 Newton Street
    PA16 8SG Greenock
    Renfrewshire
    Administrateur
    Glenside 89 Newton Street
    PA16 8SG Greenock
    Renfrewshire
    British32014420001
    BRADY, John Mccann
    88 Talbot Terrace
    G13 3RX Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    88 Talbot Terrace
    G13 3RX Glasgow
    Lanarkshire
    British7690001
    CHAPMAN, Malcolm Neil
    32 Whitelea Court
    PA13 4LA Kilmacolm
    Renfrewshire
    Administrateur
    32 Whitelea Court
    PA13 4LA Kilmacolm
    Renfrewshire
    British25915990002
    CLARK, Thomas Andrew
    Clifton
    Kilbarchan Road
    PA11 3EG Bridge Of Weir
    Administrateur
    Clifton
    Kilbarchan Road
    PA11 3EG Bridge Of Weir
    British27503050001
    COOPER, James
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandBritish929150002
    DELANEY, Luke
    2 Barons Gate
    Bothwell
    G71 8SJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Barons Gate
    Bothwell
    G71 8SJ Glasgow
    Lanarkshire
    British7940001
    EVANS, William Wilson
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    Administrateur
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    ScotlandBritish414930001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Administrateur
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritish50219540001
    FRASER, George Gabriel
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    Administrateur
    7 Fairways
    Altonburn Road
    IV12 5NB Nairn
    Highland
    ScotlandBritish50219540001
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Administrateur
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    ScotlandBritish36657620002
    HEWITT, John Peter
    The Old Rectory Burnby Pocklington
    YO42 1RS York
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Old Rectory Burnby Pocklington
    YO42 1RS York
    North Yorkshire
    EnglandBritish4039230001
    HOLMES, Michael Joseph
    107 West King Street
    G84 8DQ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    107 West King Street
    G84 8DQ Helensburgh
    Dunbartonshire
    British67358180001
    HUGHES, Gerald John
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritish114922340001
    HYND, Russell John
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    British62990090002
    KIRKPATRICK, Ian
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    Administrateur
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish31693560001
    LANG, William
    Glen Cottage
    G82 5ES Bloomhill
    Cardross
    Administrateur
    Glen Cottage
    G82 5ES Bloomhill
    Cardross
    ScotlandBritish78596060001
    LUNDY, Robert
    Langdene
    Moredun Road
    PA2 9LH Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    Langdene
    Moredun Road
    PA2 9LH Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish841310001
    MATHESON, Alexander
    5 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    Administrateur
    5 Feddon Hill
    IV10 8SP Fortrose
    Ross Shire
    United KingdomBritish408410001
    MCKEE, John Eaglesham
    Polbae
    G46 6TF Whitecraigs
    Administrateur
    Polbae
    G46 6TF Whitecraigs
    British7680001
    MCKENDRICK, Ian Dempster
    36 St Germains
    Bearsden
    G61 2RS Glasgow
    Administrateur
    36 St Germains
    Bearsden
    G61 2RS Glasgow
    British7650003
    MCKIE, Robert Gordon
    10 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    Administrateur
    10 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    United KingdomBritish62013870001
    MOORE, John Cooperwhite
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    British100327920001
    SMITH, Michael Andrew
    Flat 1r, 198 Wilton Street
    G20 6BL Glasgow
    Administrateur
    Flat 1r, 198 Wilton Street
    G20 6BL Glasgow
    British65926290002
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    WHITEFORD, Matthew James
    19 Crosswood Crescent
    EH14 7LX Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    19 Crosswood Crescent
    EH14 7LX Balerno
    Midlothian
    ScotlandBritish83553340001
    WRIGHT, Daniel Whitelaw, Professor
    Blair Mill
    KA24 4EY Dalry
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    Blair Mill
    KA24 4EY Dalry
    Ayrshire
    Scotland
    United KingdomBritish4974690001

    SEMPLE PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 06 août 2002
    Livré le 09 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 août 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 mai 2005Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (1 Scot)
    • 06 juil. 2006Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
    • 115 nov. 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (3 Scot)
      • Numéro de dossier 1
    Standard security
    Créé le 27 mars 2000
    Livré le 31 mars 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12 & 14 william street, paisley.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 31 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 29 mars 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 29 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 27 mars 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 27 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 01 nov. 1991
    Livré le 12 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 12 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 mai 1984
    Livré le 04 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 387.93 sq yds in paisley.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 04 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 août 1981
    Livré le 24 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Workshop and offices at 14 william street, paisley.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 août 1981Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond of cash credit & floating charge
    Créé le 09 févr. 1970
    Livré le 24 févr. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 févr. 1970Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & disposition in security & assignation & minute of agreement
    Créé le 01 nov. 1968
    Livré le 11 nov. 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000
    Brèves mentions
    Dwellinghouse 108 corsbar road, paisley & policies of assurance. See col(3) of doc 29.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Heritable Securities and Mortgage Investment Association
    Transactions
    • 11 nov. 1968Enregistrement d'une charge
    • 23 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SEMPLE PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 août 2002Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    practitioner
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    Matthew Purdon Henderson
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    practitioner
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0