DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED

DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC032804
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    legacy

    5 pagesMG03s

    legacy

    6 pagesMG03s

    legacy

    9 pagesMG03s

    legacy

    8 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Finance House Orchard Brae Edinburgh EH4 1PF le 23 juin 2011

    3 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 mai 2011

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2010

    5 pagesAAMD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2011

    État du capital au 04 mars 2011

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Hopkins en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Patrick White le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy Mark Blackwell le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Nomination de Stephen John Hopkins en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Jarvis en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLACKWELL, Timothy Mark
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Administrateur
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish124967310001
    WHITE, Adrian Patrick
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    Administrateur
    Tresillian Terrace
    CF10 5BH Cardiff
    St William House
    United Kingdom
    EnglandBritish130578200001
    HOPKINS, Stephen John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Secrétaire
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    British146429300001
    JARVIS, David
    10 Convent Close
    BR3 5GD Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    10 Convent Close
    BR3 5GD Beckenham
    Kent
    British71325200001
    KILBEE, Michael Peter
    2 Westdene Way
    KT13 9RG Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    2 Westdene Way
    KT13 9RG Weybridge
    Surrey
    British19310990001
    O'CONNOR, Sharon Noelle
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Secrétaire
    176 Blagdon Road
    KT3 4AL New Malden
    Surrey
    Irish45487120003
    BURY, James Michael
    9 Turnpike Close
    Dinas Powys
    CF64 4HT Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    9 Turnpike Close
    Dinas Powys
    CF64 4HT Cardiff
    South Glamorgan
    British89914600001
    DAVIES, John Lewis
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    Administrateur
    68 The Plain
    CM16 6TW Epping
    Essex
    British51486560001
    FRANCIS, Paul David
    2 Mark Way
    GU7 2BE Godalming
    Surrey
    Administrateur
    2 Mark Way
    GU7 2BE Godalming
    Surrey
    British268390001
    HOOK, Peter Francis
    Treetops
    8 Queenswood Drive
    BH22 9SU Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    Treetops
    8 Queenswood Drive
    BH22 9SU Ferndown
    Dorset
    EnglandBritish8570270001
    KILBEE, Michael Peter
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Wychway
    Cavendish Road
    KT13 0JW Weybridge
    Surrey
    British19310990002
    MACAULEY, Richard Edward
    The New Farmhouse
    Gt Chesterford
    CB10 1PH Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    The New Farmhouse
    Gt Chesterford
    CB10 1PH Saffron Walden
    Essex
    British268400001
    POTTS, David Keith
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    23 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish5774320002

    DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Equitable charge
    Créé le 31 déc. 1974
    Livré le 20 janv. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £7,000,000. all further moneys due, or to become due from the company to chargee and others
    Brèves mentions
    Benefit of a contract is constitated by the service of an option notice dd. 31/12/74 (copy annexed hereto) the general properties sit out in the schedule to the option notice (annexed hereto).
    Personnes ayant droit
    • Guardian Assurance
    • Commercial Union Assurance Co. LTD
    • Phoenix Assurance Company LTD
    Transactions
    • 20 janv. 1975Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Further guarantee and debenture
    Créé le 15 févr. 1974
    Livré le 01 mars 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Phoenix Ass. Co. LTD
    • Cin Properties LTD
    • Unilever Superan. Trustees LTD
    • Electricity Supply Nominees LTD
    Transactions
    • 01 mars 1974Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 15 févr. 1974
    Livré le 01 mars 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Unilever Superan. Trustees LTD
    • Electricity Supply Nominees LTD
    • Cin Properties LTD
    • Phoenix Ass. Co. LTD
    Transactions
    • 01 mars 1974Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Guarantee and debenture
    Créé le 15 févr. 1974
    Livré le 20 févr. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1974Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 janv. 1974
    Livré le 15 févr. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Unilever Superannuation Trustees Limited
    Transactions
    • 15 févr. 1974Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 janv. 1974
    Livré le 29 janv. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due
    Brèves mentions
    Whole assets of company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1974Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 déc. 1973
    Livré le 24 déc. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies owing from time to time
    Brèves mentions
    All property vested in the company now and in future.
    Personnes ayant droit
    • Phoenix Assurance Company LTD
    • Cin Properties LTD
    • Electricity Supply Nominees LTD
    • Unilever LTD
    Transactions
    • 24 déc. 1973Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 déc. 1973
    Livré le 08 janv. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All freehold and leasehold property of the company to the title to which is registered at hm. Land registry. All buildings fixture & plant machinery thereon.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1974Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Legal charge
    Créé le 10 déc. 1973
    Livré le 21 déc. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Not less than £12,500,000 and up to £25,000,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property assets present and future of the company.
    Personnes ayant droit
    • Unilever Superanuation Trustees LTD
    • Electricity Supply Nominees LTD
    • Phoenix Assurance Company LTD
    • (In Properties) LTD
    Transactions
    • 21 déc. 1973Enregistrement d'une charge
    • 28 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)

    DRUMSHEUGH PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 juin 2012Dissolved on
    24 mai 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0