DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED

DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC034659
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    • Vente de voitures neuves et de véhicules légers (45111) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Vente de voitures d'occasion et de véhicules légers (45112) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Entretien et réparation de véhicules automobiles (45200) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HENRY BROTHERS (GLASGOW) LIMITED15 déc. 195915 déc. 1959

    Quels sont les derniers comptes de DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    12 pagesAA

    Notification de Parks of Hamilton (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant qu'administrateur le 17 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que directeur le 03 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2017

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Graeme Thomas Park en tant qu'administrateur le 01 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Douglas Ireland Park en tant qu'administrateur le 01 nov. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 sept. 2015

    État du capital au 03 sept. 2015

    • Capital: GBP 97,500
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Douglas Ireland Park en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 sept. 2013

    État du capital au 12 sept. 2013

    • Capital: GBP 97,500
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NOBLE, Alasdair George
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Secrétaire
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    238723710001
    BRYCE, Alexander Stewart
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    United KingdomBritish150803460001
    CUMMING, William
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    United KingdomBritish112830750001
    MACKAY, Ian Barron
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    ScotlandBritish406430001
    NOBLE, Alasdair George
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    ScotlandBritish240301140001
    PARK, Douglas Ireland
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    SwitzerlandBritish202387330001
    PARK, Graeme Thomas
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    ScotlandBritish172685990001
    PARK, Ross William
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    ScotlandBritish93072080001
    CLARK, Diane Christine
    Park Lodge
    Henry Street
    FK3 9JB Grangemouth
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Park Lodge
    Henry Street
    FK3 9JB Grangemouth
    Stirlingshire
    American53621620002
    DONNACHIE, Gerard
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Secrétaire
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    British602380003
    HENRY, Alexander Richmond
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    British18160001
    BROWN, Steve
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Snead View
    ML1 5GL Motherwell
    Lanarkshire
    British112830890001
    DONNACHIE, Gerard
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    United KingdomBritish602380003
    HENRY, Alexander Richmond
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish18160001
    HENRY, Carol
    9 Elphinstone Road
    G46 6TE Glasgow
    Administrateur
    9 Elphinstone Road
    G46 6TE Glasgow
    American920040001
    HENRY, Dorothy Grace
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    82 St Andrews Drive
    G41 4EQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandAmerican18180001
    HENRY, Norman James
    High Noon, 9 Elphinstone Road
    Whitecraigs
    G46 6TE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    High Noon, 9 Elphinstone Road
    Whitecraigs
    G46 6TE Glasgow
    Lanarkshire
    British126196200001
    PARK, Douglas Ireland
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    Administrateur
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    GibraltarBritish333600008

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Douglas Park (Glasgow) Limited
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSc173701
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Parks Of Hamilton (Holdings) Limited
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSc066568
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DOUGLAS PARK (HILLINGTON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 13 févr. 2007
    Livré le 14 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 avr. 1998
    Livré le 05 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mai 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 mars 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 29 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 24 juin 1997
    Livré le 07 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3-33 (odd numbers) kyle street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Bmw Financial Services (GB) Limited
    Transactions
    • 07 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 20 juin 1997
    Livré le 24 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All new and used motor vehicles.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bmw Financial Services (GB) Limited
    Transactions
    • 24 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juin 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Assignation in security
    Créé le 16 janv. 1989
    Livré le 19 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment bases. Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Bmw Finance (GB) LTD., London
    Transactions
    • 19 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3/33 kyle st glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation in security
    Créé le 18 juil. 1986
    Livré le 28 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies from which time to time be owing to the company by bmw (GB) LTD in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to B.M.w GB LTD by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 28 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 mars 1982
    Livré le 08 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies which may from time to time by owing to the company by bmw (GB) LTD in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to B.M.w by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds and Scottish Trust LTD
    Transactions
    • 08 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 23 févr. 1982
    Livré le 08 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Portion of ground at 10 abbey drive, jordanhills glasgow, parish and county of govan.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 mars 1982Enregistrement d'une charge
    • 20 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 1982
    Livré le 27 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 24 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0